Actos BORME de Siro Jaen Sociedad Limitada
20 de Septiembre de 2023Cambio de denominaci贸n social. CEREALTO JAEN, SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 493 , F 110, S 8, H J 18434, I/A34 (12.09.23).
17 de Mayo de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: FONTS CAVESTANY JUAN BOSCO. Datos registrales. T 493 , F 108, S 8, H J 18434, I/A 33 (8.05.23).
13 de Marzo de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 493 , F 108, S 8, H J 18434, I/A 62 ( 6.03.23).
10 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ GARCIA MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 493 , F 108, S 8, H J 18434, I/A 31 ( 2.03.23).
03 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO;ESCUDERO PERAL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 493, F 107, S 8, H J 18434, I/A 28 (27.01.23).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: CEM KARAKAS HALIL.Datos registrales. T 493 , F 107, S 8, H J 18434, I/A 30 (27.01.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TAPIA BAJO LORENZA;LOPEZ MARTIN LUIS ANGEL. Datos registrales. T 493 , F 107, S 8, H J18434, I/A 29 (27.01.23).
08 de Febrero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ ANTONIO;RODRIGUEZ BALDOMINOS CARMEN MARIA;RUBIA PRADANA MARINA.Datos registrales. T 493 , F 107, S 8, H J 18434, I/A 27 ( 2.02.22).
21 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: TURA ROF JOSE;MARTIN CARDIEL CARLOS ENRIQUE. Datos registrales. T 493 , F 107, S 8, H J18434, I/A 26 (17.01.22).
30 de Diciembre de 2021Nombramientos. Auditor: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 493 , F 106, S 8, H J 18434, I/A 25 (23.12.21).
02 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA VIUDA SAINZ JAVIER. Datos registrales. T 493 , F 106, S 8, H J 18434, I/A 24 (26.01.21).
18 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMERAL DURO VICTORIANO JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA VIUDA SAINZJAVIER. Datos registrales. T 493 , F 105, S 8, H J 18434, I/A 23 (11.03.20).
02 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ LOPEZ ANTONIO;RODRIGUEZBALDOMINOS CARMEN MARIA;RUBIA PRADANA MARINA;DIEZ ALONSO MERCEDES;HERRERO CALLE MARIA DE LOSMILAGROS;GOMEZ GARCIA MARIA DEL PILAR;NIETO MATE SANDRA. Datos registrales. T 493 , F 104, S 8, H J 18434, I/A 22(19.12.19).
18 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ MARTIN LUIS ANGEL. Datos registrales. T 493 , F 102, S 8, H J 18434, I/A 21 (10.07.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ DEL AGUA MARTA;RODRIGUEZ MORENO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T493 , F 100, S 8, H J 18434, I/A 19 ( 2.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: TURA ROF JOSE;MARTIN CARDIEL CARLOS ENRIQUE. Datos registrales. T 493 , F 101, S 8, H J18434, I/A 20 ( 2.04.19).
03 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 493 , F 100, S 8, H J 18434, I/A 18 (27.12.18).
28 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ ALONSO CRISTINA DE LOS REYES. Datos registrales. T 493 , F 99, S 8, H J 18434, I/A 17(21.11.18).
19 de Junio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ RODRIGUEZ ALVARO;HERRERO CALLE MARIA DE LOS MILAGROS. Datos registrales. T493 , F 99, S 8, H J 18434, I/A 15 (13.06.17).
Revocaciones. Apoderado: BENITO BENITO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 493 , F 99, S 8, H J 18434, I/A 16(13.06.17).
25 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 493 , F 98, S 8, H J 18434, I/A 14 (17.08.15).
19 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ROMERAL DURO VICTORIANO JOSE. Datos registrales. T 493 , F 97, S 8, H J 18434, I/A 12(12.01.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PALENZUELA GARCIA MARIA JESUS. Apo.Manc.: PALENZUELA GARCIA MARIA JESUS;OTEROLUCAS CESAR;TAPIA BAJO LORENZA. Datos registrales. T 493 , F 98, S 8, H J 18434, I/A 13 (12.01.15).
28 de Octubre de 2014Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SERNA VIRGINIA;OTERO LUCAS CESAR. Apoderado: GONZALEZ SERNA VIRGINIA.Datos registrales. T 493 , F 97, S 8, H J 18434, I/A 11 (20.10.14).
26 de Marzo de 2014Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SERNA VIRGINIA. Datos registrales. T 493 , F 96, S 8, H J 18434, I/A 10 (19.03.14).
02 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ ALONSO CRISTINA DE LOS REYES. Datos registrales. T 493 , F 95, S 8, H J 18434, I/A 9(25.11.13).
12 de Diciembre de 2011Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 493 , F 95, S 8, H J 18434, I/A 8 (29.11.11).
02 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.772.345,06 Euros. Resultante Suscrito: 12.775.351,06 Euros. Datos registrales. T 492 , F 67, S8, H J 18434, I/A 6 (24.10.11).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GALLETAS SIRO SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 493, F 95, S 8, H J 18434, I/A 7 (24.10.11).
07 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: BENITO BENITO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 480 , F 207, S 8, H J 18434, I/A 5(27.09.11).
03 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: TAPIA BAJO LORENZA;OTERO LUCAS CESAR;PALENZUELA GARCIA MARIA JESUS. Datosregistrales. T 480 , F 205, S 8, H J 18434, I/A 3 (22.09.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SERNA VIRGINIA;OTERO LUCAS CESAR;PALENZUELA GARCIA MARIAJESUS;TAPIA BAJO LORENZA. Datos registrales. T 480 , F 205, S 8, H J 18434, I/A 4 (22.09.11).
08 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN YA脩EZ ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ SERNA JUAN MANUEL.Datos registrales. T 480 , F 205, S 8, H J 18434, I/A 2 (31.08.11).
07 de Marzo de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.04.11. Objeto social: 1. La fabricaci贸n, almacenaje, compraventa, comercializacion ydistribucion de productos propios de reposteria y pasteleria, tales como bollos, pastas, galletas, pan de todas clases y similares, asicomo de productos alimenticios en general, tanto frescos como refrigerados y congelados. 2. La presta. Domicilio: CTRA DE MADRIDS/N (JAEN). Capital: 3.006,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NUTREXPA SL. Nombramientos. Adm.Unico: MARTIN YA脩EZ ANTONIO. Datos registrales. T 480 , F 203, S 8, H J 18434, I/A 1 (23.02.11).