Actos BORME de Sistem Melesur Energia Sa
02 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MIRALLES LUIS MARIA;GANADO OLMEDO JOSE FRANCISCO;GOMEZ MORAN JORGENEBOT;AYERBE CALVO ENRIQUE-JAVIER;BOLPILLAR GUTIERREZ RAFAEL;CARRALERO ALBA CARLOS;GAMIZ DE LA ROSAEDUARDO;HIDALGO CARDADOR JUAN;BARLARI URRUTIA JUAN ALEXIS;LOPEZ MOLINA JUAN CARLOS;MUÑOZ MARTINMIGUEL ANGEL;CAMACHO CARRANZA JOSE MARIA;SALMERON FERNANDEZ JOSE CARLOS;RODRIGUEZ SUAREZFATIMA;CAICOYA FERREIRO JARA MARIA;CASTRO MORA MARIANE DEL VALLE;GONZALEZ ORGAZ DIDIER;NEVADOGUTIERREZ JORGE;MARTINEZ ROCA LETICIA;DE ORAA GIL GABRIEL;PARRON YUSTE JOSE RODRIGO. Datos registrales. T7226 , F 120, S 8, H SE134948, I/A 8 (25.07.23).
28 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7226 , F 120, S 8, H SE134948, I/A 7 (21.03.23).
11 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOLPILLAR GUTIERREZ RAFAEL;SALMERON FERNANDEZ JOSE CARLOS;LOPEZ MOLINAJUAN CARLOS;AYERBE CALVO ENRIQUE-JAVIER;GAMIZ DE LA ROSA EDUARDO;MUÑOZ MARTIN MIGUELANGEL;CARRALERO ALBA CARLOS. Datos registrales. T 7226 , F 118, S 8, H SE134948, I/A 6 ( 3.01.23).
16 de Diciembre de 2022Otros conceptos: La Sociedad Revoca el Poder No inscrito, conferido a favor de Doña María-José Bello Pardillos, en virtud deescritura otorgada en la Villa de Madrid, el día veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, ante el notario don Miguel Yuste Rojas,número 4.104 de protocolo. Datos registrales. T 7226 , F 118, S 8, H SE134948, I/A 5 ( 9.12.22).
12 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: AYERBE CALVO ENRIQUE-JAVIER. Datos registrales. T 7226 , F 118, S 8, H SE134948, I/A 4(30.11.22).
28 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 7226 , F 118, S 8, H SE134948, I/A 3 (18.11.22).
02 de Junio de 2022Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 3º. Domicilio social. Cambio de domicilio social. AVDA DE DIEGOMARTINEZ BARRIO 10 7ª - CP 41013 (SEVILLA). Datos registrales. T 7226 , F 117, S 8, H SE134948, I/A 2 (26.05.22).
06 de Abril de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: ANDUJAR GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 43, S 8, H MA 18113, I/A 67(29.03.22).
31 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: CASTRO MORA MARIANE DEL VALLE. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 42, S 8, H MA 18113,I/A 65 (22.03.22).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ORAA GIL GABRIEL;RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 42,S 8, H MA 18113, I/A 66 (22.03.22).
11 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: GALDOS QUEVEDO JAVIER;GALDOS QUEVEDO JAVIER. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 41,S 8, H MA 18113, I/A 63 (30.12.21).
Revocaciones. Apoderado: NIETO BALLESTEROS LUIS. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 41, S 8, H MA 18113, I/A 64(30.12.21).
13 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: CASTRO MAILLO RAFAEL;LILLO MARQUEZ CARLOS JAVIER. Apo.Man.Soli: LILLO MARQUEZCARLOS JAVIER. Apo.Sol.: YERA DIEZ JUAN LUIS;IBAÑEZ SORIA SERGIO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GAMBOA ESPERANZA.Datos registrales. T 6014, L 4921, F 7, S 8, H MA 18113, I/A 59 ( 5.10.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VELARDE MAZA PEDRO. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 7, S 8, H MA 18113, I/A 60 (5.10.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALDOS QUEVEDO JAVIER. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 40, S 8, H MA 18113, I/A 61 (5.10.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALDOS QUEVEDO JAVIER. Datos registrales. T 6076, L 4983, F 41, S 8, H MA 18113, I/A 62 (5.10.21).
10 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ SUAREZFATIMA. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 7, S 8, H MA 18113, I/A 58 ( 2.08.21).
30 de Julio de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ MARTIN AGUSTIN. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 5, S 8, H MA 18113, I/A 56(23.07.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GAMBOA ESPERANZA. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 6, S 8, H MA 18113, I/A57 (23.07.21).
15 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER. Presidente: CABRERA CASADO FRANCISCOJAVIER. Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Presidente: DE ORAA GILGABRIEL. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 5, S 8, H MA 18113, I/A 55 ( 7.07.21).
16 de Junio de 2021Revocaciones. Apoderado: MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: MORILLA MUÑOZ FRANCISCOJAVIER;BELMONTE URBANO SANDRA;MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER;MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 6014, L 4921, F 4, S 8, H MA 18113, I/A 54 ( 8.06.21).
15 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: GOYENECHE PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 4, S 8, H MA 18113, I/A 52 (7.06.21).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SUAREZ FATIMA. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 4, S 8, H MA 18113, I/A 53 (
08 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER;GOMEZ MORAN JORGE NEBOT;GANADO OLMEDOJOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 1, S 8, H MA 18113, I/A 49 (26.03.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ GALVEZ MARIA DEL CARMEN;JIMENEZ SALAS PEDRO;CABAÑERO QUINTANAFERNANDO;SUAREZ BILBAO IKER;ANDUJAR GARCIA MIGUEL ANGEL;YERA DIEZ JUAN LUIS;IBAÑEZ SORIA SERGIO. Datosregistrales. T 6014, L 4921, F 2, S 8, H MA 18113, I/A 50 (26.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: AMATLLE PANADES JOAN. Datos registrales. T 6014, L 4921, F 3, S 8, H MA 18113, I/A 51(26.03.21).
31 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: PINA SANCHEZ ARJONA ANGELGONZALO;GONZALEZ NAVARRO ALBERTO. Apoderado: ALMOGUERA BERMEJO JOSE PATRICIO;CEBRIAN VAZQUEZALBERTO;BLANC MARUGAN ALVARO. Apo.Man.Soli: PONTES JIMENEZ JAVIER;TRIANO REYES CARMEN. Datos registrales. T6014, L 4921, F 1, S 8, H MA 18113, I/A 48 (23.03.21).
15 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER;GOMEZ MORAN JORGE NEBOT;GANADO OLMEDOJOSE FRANCISCO. Datos registrales. T 5906, L 4813, F 10, S 8, H MA 18113, I/A 47 ( 4.03.21).
09 de Junio de 2020Revocaciones. Aud.Supl.: FERNANDEZ PUERTAS VICTOR MANUEL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datosregistrales. T 5906, L 4813, F 10, S 8, H MA 18113, I/A 46 ( 1.06.20).
06 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER;MORILLA MUÑOZ FRANCISCO JAVIER;GOYENECHEPEREZ FERNANDO;PONTES JIMENEZ JAVIER;MARQUEZ LILLO CARLOS JAVIER;BELMONTE URBANO SANDRA;TRIANOREYES CARMEN. Datos registrales. T 5906, L 4813, F 9, S 8, H MA 18113, I/A 45 (27.01.20).
08 de Enero de 2020Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Consejero: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER;VENTURA DE ALMEIDA JULIO MANUEL;CLECHLAURENT JEAN LOUIS;DE ORAA GIL GABRIEL. Presidente: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER. Secretario: CLECHLAURENT JEAN LOUIS. Cons.Del.Sol: CABRERA CASADO FRANCISCO JAVIER;CLECH LAURENT JEAN LOUIS. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. MODIFICACION TOTAL DELOS ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 5639, L 4546, F 109, S 8, H MA 18113, I/A 44 (20.12.19).
14 de Octubre de 2019Reducción de capital. Importe reducción: 5.000.049,40 Euros. Resultante Suscrito: 1.120.174,00 Euros. Datos registrales. T 5639,L 4546, F 109, S 8, H MA 18113, I/A 43 ( 4.10.19).
07 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apoderado: HIDALGO CARDADOR JUAN. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 107, S 8, H MA 18113, I/A 41(28.11.18).
Nombramientos. Apoderado: BLANC MARUGAN ALVARO. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 108, S 8, H MA 18113, I/A 42(28.11.18).
16 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRAQUEHAIS LUMBRERAS TECLA. Nombramientos. Adm. Unico: CABRERA CASADOFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 107, S 8, H MA 18113, I/A 40 (31.10.18).
01 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: CASTILLA AGUILAR RAFAEL JAVIER. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 107, S 8, H MA 18113, I/A39 (21.09.18).
02 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: NEVADO GUTIERREZ JORGE. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 107, S 8, H MA 18113, I/A 38(15.03.18).
27 de Marzo de 2018Otros conceptos: Rectificación de la inscripción 35ª, quedando inscrito como Auditor de Cuentas TITULAR, la entidad "ABACONSULTORES Y AUDITORES DE CUENTAS, S.L.", y como Auditor de Cuentas SUPLENTE, DON VICTOR MANUEL FERNANDEZPUERTAS.- Datos registrales. T 5639, L 4546, F 106, S 8, H MA 18113, I/A 37 (15.03.18).
13 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: MARQUEZ LILLO CARLOS JAVIER. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 106, S 8, H MA 18113, I/A36 ( 1.02.18).
16 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: FERNANDEZ PUERTAS VICTOR MANUEL. Aud.Supl.: ABA CONSULTORES Y AUDITORES DECUENTAS SL. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 106, S 8, H MA 18113, I/A 35 ( 8.01.18).
04 de Agosto de 2017Nombramientos. Apoderado: NIETO BALLESTEROS LUIS. Datos registrales. T 5639, L 4546, F 105, S 8, H MA 18113, I/A 34(26.07.17).
25 de Julio de 2017Ampliación de capital. Suscrito: 6.000.023,40 Euros. Desembolsado: 6.000.023,40 Euros. Resultante Suscrito: 6.120.223,40 Euros.Resultante Desembolsado: 6.120.223,40 Euros. Datos registrales. T 5345, L 4252, F 37, S 8, H MA 18113, I/A 33 (14.07.17).
22 de Febrero de 2017Nombramientos. Apoderado: CEBRIAN VAZQUEZ ALBERTO. Datos registrales. T 5345, L 4252, F 36, S 8, H MA 18113, I/A 32(13.02.17).