Actos BORME de Sistema De Evacuacion Albuera Set Olivenza-vaguadas Aie
15 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO. Nombramientos. Adm. Mancom.: PICAZO MURPABLO. Datos registrales. T 33758 , F 208, S 8, H M 607611, I/A 12 ( 8.06.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: SIERRA ALBERT JORGE;SAENZ DENIS JAIME LUIS;GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SIERRA ALBERT JORGE;SAENZ DENIS JAIME LUIS;PICAZO MUR PABLO. Datos registrales. T33758 , F 208, S 8, H M 607611, I/A 13 ( 8.06.21).
18 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO;SAENZ DENIS JAIME LUIS;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: SIERRA ALBERT JORGE;SAENZ DENIS JAIME LUIS;GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO.Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS NUMERO 16 D, PLANTA 10 (MADRID). Datos registrales. T 33758 , F 207, S 8,H M 607611, I/A 11 (11.05.21).
19 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Nombramientos. Representan: SIERRA ALBERT JORGE.Datos registrales. T 33758 , F 206, S 8, H M 607611, I/A 9 ( 9.10.20).
Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Nombramientos. Representan: SIERRA ALBERT JORGE.Datos registrales. T 33758 , F 206, S 8, H M 607611, I/A 10 ( 9.10.20).
07 de Septiembre de 2020Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Nombramientos. Representan: SIERRA ALBERT JORGE.Datos registrales. T 33758 , F 206, S 8, H M 607611, I/A 8 (31.08.20).
25 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALVAREZ CABREROS GREGORIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ CABREROSGREGORIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: GARCIA RODRIGUEZ JOSE BENITO. Apo.Man.Soli: GARCIA RODRIGUEZ JOSEBENITO;SAENZ DENIS JAIME LUIS;GONZALEZ HIERRO FRANCISCO. Datos registrales. T 33758 , F 205, S 8, H M 607611, I/A 7
10 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: GONZALEZ HIERROFRANCISCO. Datos registrales. T 33758 , F 204, S 8, H M 607611, I/A 6 ( 3.04.19).
20 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS - 16 D, 3潞 I (MADRID). Datos registrales. T 33758 , F 204, S 8, H M 607611, I/A 5(13.11.17).
10 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: CORTES APARICIO MANUEL. Nombramientos. Representan: GONZALEZ HIERROFRANCISCO. Datos registrales. T 33758 , F 204, S 8, H M 607611, I/A 3 (30.06.17).
Ceses/Dimisiones. Representan: CORTES APARICIO MANUEL. Nombramientos. Representan: GONZALEZ HIERROFRANCISCO. Datos registrales. T 33758 , F 204, S 8, H M 607611, I/A 4 (30.06.17).
15 de Octubre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALVAREZ CABREROS GREGORIO. Apo.Manc.: EXTRESOL 1 SL;EXTRESOL 2 SOCIEDADLIMITADA;EXTRESOL-3 SOCIEDAD LIMITADA;SAENZ DENIS JAIME LUIS. Datos registrales. T 33758 , F 203, S 8, H M 607611,I/A 2 ( 7.10.15).
29 de Septiembre de 2015Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.10.13. Objeto social: la colaboraci贸n entre sus socios para facilitar la operaci贸n,mantenimiento y explotaci贸n de las infraestructuras necesarias para la conexi贸n de las plantas termosolares denominadas Extresol-1,Extresol-2, Extresol-3, Astexol-2 y Olivenza-1 (las "Plantas"),. Domicilio: C/ CARDENAL MARCELO SPINOLA 10 (MADRID). Capital:10.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Mancom.: EXTRESOL 1 SL;EXTRESOL 2 SOCIEDAD LIMITADA;EXTRESOL-3SOCIEDAD LIMITADA;ALVAREZ CABREROS GREGORIO;SAENZ DENIS JAIME LUIS. Representan: MARTINEZ DALMAU JOSELUIS;CORTES APARICIO MANUEL;CORTES APARICIO MANUEL. Datos registrales. T 33758 , F 195, S 8, H M 607611, I/A 1(21.09.15).