Buscador CIF Logo

Actos BORME Sistema Efactura Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sistema Efactura Sl

Actos BORME Sistema Efactura Sl - B88554589

Tenemos registrados 8 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sistema Efactura Sl con CIF B88554589

馃敊 Perfil de Sistema Efactura Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sistema Efactura Sl

26 de Abril de 2023
Cambio de denominaci贸n social. UNIFIEDPOST SL. Datos registrales. T 40057 , F 74, S 8, H M 711713, I/A 8 (19.04.23).

30 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: LATORRE MARLASCA JUAN MARIA. Nombramientos. VsecrNoConsj: ROVIRA DIEZ PABLOLUIS. Datos registrales. T 40057 , F 72, S 8, H M 711713, I/A 6 (23.06.22).

Revocaciones. Apoderado: ROVIRA DIEZ PABLO LUIS. Nombramientos. Apoderado: ROVIRA DIEZ PABLO LUIS. Datosregistrales. T 40057 , F 72, S 8, H M 711713, I/A 7 (23.06.22).

05 de Julio de 2021
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: UNIFIEDPOST GROUP NV/SA. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj:CANTA DIAZ DE GUERE脩U JORGE. VsecrNoConsj: RIVERA GARCIA DIANA. Consejero: JOHANNES KJELLEN DANIEL.Presidente: JOHANNES KJELLEN DANIEL. Consejero: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO;ARIAS CASANOVARAFAEL;HEDBERG FREDIK;JESPER HENRIKSSON JOHN ROBERT. Nombramientos. Consejero: LEYBAERT HANS ALBERTM;VAN ACKER TOM SIMONNE G;MARCELIS LAURENT HENRI. Presidente: LEYBAERT HANS ALBERT M. Secretario: VAN ACKERTOM SIMONNE G. VsecrNoConsj: LATORRE MARLASCA JUAN MARIA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADO ELARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 19 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Datos registrales. T 40057 , F 69, S 8, H M 711713, I/A 4 (28.06.21).

Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO. Nombramientos. Apoderado: ROVIRA DIEZ PABLO LUIS.Datos registrales. T 40057 , F 71, S 8, H M 711713, I/A 5 (28.06.21).

16 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO. Datos registrales. T 40057 , F 67, S 8, H M 711713, I/A 3 (9.12.20).

15 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO;ARIAS CASANOVA RAFAEL;SANCHEZ CARRE脩OALFONSO;VALLEJO LLOPIS JUAN;CHESTER-BERGARECHE MENDOZA NICOLAS. Presidente: GONZALEZ MAC DOWELLARTURO. Con.Delegado: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO. SecreNoConsj: MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE.Nombramientos. SecreNoConsj: CANTA DIAZ DE GUERE脩U JORGE. VsecrNoConsj: RIVERA GARCIA DIANA. Consejero:JOHANNES KJELLEN DANIEL. Presidente: JOHANNES KJELLEN DANIEL. Consejero: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO;ARIASCASANOVA RAFAEL;HEDBERG FREDIK;JESPER HENRIKSSON JOHN ROBERT. Datos registrales. T 40057 , F 67, S 8, H M711713, I/A 2 ( 7.12.20).

17 de Febrero de 2020
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 19.12.19. Objeto social: a) La prestaci贸n del servicio de facturaci贸n digital online parapymes, grandes empresas y administraciones p煤blicas. b) La prestaci贸n de servicios de informaci贸n agregada sobre datos financierosdistintos a informaci贸n sobre cuentas de pago y sobre datos no financieros. Domicilio: C/ MUSGO 3 - 1陋 PLANTA (MADRID). Capital:100.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: EUROBITS TECHNOLOGIES SL. Nombramientos. Consejero:GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO;ARIAS CASANOVA RAFAEL;SANCHEZ CARRE脩O ALFONSO;VALLEJO LLOPISJUAN;CHESTER-BERGARECHE MENDOZA NICOLAS. Presidente: GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO. Con.Delegado:GONZALEZ MAC DOWELL ARTURO. SecreNoConsj: MEJIAS VILLATORO PEDRO JOSE. Datos registrales. T 40057 , F 60, S 8, HM 711713, I/A 1 (10.02.20).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n