Actos BORME de Sistemas Energeticos Boyal Sociedad Limitada
30 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: CAAMAÑO MARTINEZ LUIS CLAUDIO. Consejero: CAAMAÑO MARTINEZ LUIS
Revocaciones. Apo.Sol.: LAINEZ PEÑA MARIA DEL CARMEN. Apo.Man.Soli: PONCELA SAMPEDRO JAVIER;CAAMAÑOMARTINEZ LUIS CLAUDIO. Apo.Sol.: GONZALEZ RUIZ-JARABO JESUS. Apo.Manc.: OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS;OLIVERGOMEZ MARIANO. Nombramientos. Apo.Sol.: SABALZA GOYENECHE ROBERTO. Apo.Man.Soli: PONCELA SAMPEDROJAVIER;CUESTA BARON JOSE IGNACIO. Apo.Sol.: GUTIERREZ MENDEZ-VILLAMIL ANTONIO. Apo.Manc.: OLIVER GOMEZANTONIO JESUS;OLIVER GOMEZ MARIANO. Datos registrales. T 3930 , F 15, S 8, H Z 50969, I/A 14 (24.01.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: CAAMAÑO MARTINEZ LUIS CLAUDIO. Nombramientos. Apo.Sol.: CUESTA BARON JOSE IGNACIO.Datos registrales. T 4186 , F 187, S 8, H Z 50969, I/A 15 (24.01.23).
02 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CAAMAÑO MARTINEZ LUIS CLAUDIO;OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS;OLIVER GOMEZ MARIANO.Datos registrales. T 3930 , F 14, S 8, H Z 50969, I/A 12 (27.05.21).
04 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRIZABALAGA ALBERDI JAVIER;LAUCIRICA LARRINAGA ANTONIO EDUARDO. Presidente:ARRIZABALAGA ALBERDI JAVIER. Nombramientos. Consejero: CUESTA BARON JOSE IGNACIO;BARREIRO GRANDIO JUAN.Presidente: CAAMAÑO MARTINEZ LUIS CLAUDIO. Datos registrales. T 3930 , F 14, S 8, H Z 50969, I/A 11 (30.09.19).
19 de Abril de 2018Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9. Artículo 31º. Ejercicio social. El ejercicio social se iniciará el uno deoctubre y finalizará el treinta de septiembre de cada año". Datos registrales. T 3930 , F 13, S 8, H Z 50969, I/A 10 (12.04.18).
16 de Abril de 2018Otros conceptos: Adaptados y modificados los artículo 18 , 20º, 21º, 22º, 27º, 30º de Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades deCapital. Datos registrales. T 3930 , F 12, S 8, H Z 50969, I/A 9 ( 6.04.18).
28 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LARGO SEISDEDOS JOSE RAMON. Nombramientos. Consejero: CAAMAÑO MARTINEZ LUISCLAUDIO. Cambio de domicilio social. AVDA GOMEZ LAGUNA 25 - EDIFICIO "CEA" PLANTA 4ª, O (ZARAGOZA). Datosregistrales. T 3814 , F 133, S 8, H Z 50969, I/A 6 (19.07.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ AVECILLA GERMAN. Presidente: GONZALEZ AVECILLA GERMAN. Nombramientos.Consejero: ARRIZABALAGA ALBERDI JAVIER. Presidente: ARRIZABALAGA ALBERDI JAVIER. Datos registrales. T 3814 , F 133,S 8, H Z 50969, I/A 7 (19.07.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: LAINEZ PEÑA MARIA DEL CARMEN;GARCIA ROMEU QUINZA JOSE ENRIQUE. Apo.Man.Soli:PONCELA SAMPEDRO JAVIER;LARGO SEISDEDOS JOSE RAMON. Apo.Manc.: OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS;OLIVERGOMEZ MARIANO. Nombramientos. Apo.Sol.: LAINEZ PEÑA MARIA DEL CARMEN. Apo.Man.Soli: PONCELA SAMPEDROJAVIER;CAAMAÑO MARTINEZ LUIS CLAUDIO. Apo.Sol.: GONZALEZ RUIZ-JARABO JESUS. Apo.Manc.: OLIVER GOMEZANTONIO JESUS;OLIVER GOMEZ MARIANO. Datos registrales. T 3814 , F 133, S 8, H Z 50969, I/A 8 (19.07.16).
01 de Octubre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: LAINEZ PEÑA MARIA DEL CARMEN;GARCIA ROMEU QUINZA JOSE ENRIQUE. Apo.Man.Soli:PONCELA SAMPEDRO JAVIER;LARGO SEISDEDOS JOSE RAMON. Apo.Manc.: OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS;OLIVERGOMEZ MARIANO. Datos registrales. T 3814 , F 131, S 8, H Z 50969, I/A 5 (23.09.14).
24 de Septiembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MONZON ARRIBAS TEODORO;DOMINGO TRIADO FERNANDO;LAUCIRICA LARRINAGAANTONIO EDUARDO;OLIVER GOMEZ MARIANO;OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS. Presidente: MONZON ARRIBAS TEODORO.SecreNoConsj: SUAREZ GUTIERREZ HIPOLITO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ AVECILLA GERMAN. Presidente:GONZALEZ AVECILLA GERMAN. Consejero: MEGANIUM INVERSIONES SL. Secretario: MEGANIUM INVERSIONES SL. Consejero:LAUCIRICA LARRINAGA ANTONIO EDUARDO;LARGO SEISDEDOS JOSE RAMON;INNOVACIONES FAOLSAN SL. Cambio dedomicilio social. POLIG INDUSTRIAL SECTOR 2, ALFRED NOBEL, 4 (VILLANUEVA DE GALLEGO). Datos registrales. T 3814 , F131, S 8, H Z 50969, I/A 4 (16.09.14).
24 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R. Nombramientos. Consejero:MONZON ARRIBAS TEODORO;DOMINGO TRIADO FERNANDO;LAUCIRICA LARRINAGA ANTONIO EDUARDO;OLIVER GOMEZMARIANO;OLIVER GOMEZ ANTONIO JESUS. Presidente: MONZON ARRIBAS TEODORO. SecreNoConsj: SUAREZ GUTIERREZHIPOLITO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración.Otros conceptos: Modificados y refundidos totalmente los Estatutos sociales de la Compañía. Datos registrales. T 3814 , F 127, S8, H Z 50969, I/A 3 (14.08.12).
10 de Agosto de 2011Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 3814 , F 127, S 8, H Z 50969, I/A 2 ( 1.08.11).
24 de Diciembre de 2010Constitución. Comienzo de operaciones: 29.11.10. Objeto social: a) La promoción, construcción y explotación de instalaciones degeneraciónde energía eléctrica para la realización de actividades de investigación ydesarrollo tecnológio e innovación. b) Lapromoción, construcción y explotación de parques eólicos. c) La producción y venta de energía eléctrica. d). Domicilio: C/ ALBAREDA1B 1º A (ZARAGOZA). Capital: 3.006,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: GAMESA INVERSIONESENERGETICAS RENOVABLES SCR DE R. Nombramientos. Adm. Unico: GAMESA INVERSIONES ENERGETICAS RENOVABLESSCR DE R. Datos registrales. T 3814 , F 127, S 8, H Z 50969, I/A 1 (15.12.10).