Actos BORME de Sistemas Integrales De Mantenimiento Sa
17 de Marzo de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA. Datos registrales. T 29498, F 107, S 8, H M 74303, I/A 96 (10.03.23).
02 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: MENDEZ VEGA ALBERTO. Apo.Manc.: ALONSO GONZALEZ MARIA-JESUS. Datos registrales. T29498 , F 106, S 8, H M 74303, I/A 94 (25.11.20).
Nombramientos. Apoderado: AMORES ALONSO ALEJANDRO. Datos registrales. T 29498 , F 107, S 8, H M 74303, I/A 95(25.11.20).
11 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PAU GALCERAN JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: MANTENIMIENTO Y MONTAJESINDUSTRIALES SA. Representan: PAU GALCERAN JOSE MARIA. Datos registrales. T 29498 , F 106, S 8, H M 74303, I/A 93 (4.07.19).
07 de Mayo de 2019Cambio de domicilio social. VIA DE LOS POBLADOS 9-11 (MADRID). Datos registrales. T 29498 , F 106, S 8, H M 74303, I/A 91(26.04.19).
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE ESPINAR JUAN. Datos registrales. T 29498 , F 106, S 8, H M 74303, I/A 92 (26.04.19).
07 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE. Apoderado: SAN JOSE VAQUERO GERMAN. Datos registrales. T29498 , F 105, S 8, H M 74303,BIS , I/ 90 .(28.02.19).
08 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIEZ CALURANO JOAQUIN. Datos registrales. T 29498 , F 105, S 8, H M 74303,BIS , I/ 89.(31.05.17).
02 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: CLOTET COSTA JOSE MARIA;BRENES BERMUDEZ MANUEL;SANJUSTO PINTO DOMINGO;PALOPRUBIO CARLOS;BLASCO APARICIO FRANCISCO;PRADOS TEJADA VICENTE;RODRIGUEZ FELIPE JOSE LUIS. Apo.Man.Soli:NAVARRO LUJAN JESUS. Datos registrales. T 29498 , F 105, S 8, H M 74303,BIS , I/ 88 .(23.02.16).
16 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: GARCIA FLORES JOSE LUIS. Datos registrales. T 29498 , F 105, S 8, H M 74303, I/A 87 ( 9.12.15).
08 de Octubre de 2015Cambio de domicilio social. AVDA DE MANOTERAS 26 (MADRID). Datos registrales. T 29498 , F 104, S 8, H M 74303, I/A 86(28.09.15).
11 de Agosto de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29498 , F 104, S 8, H M 74303, I/A 85 ( 1.08.14).
04 de Agosto de 2014Reelecciones. Adm. Unico: PAU GALCERAN JOSE MARIA. Datos registrales. T 29498 , F 104, S 8, H M 74303, I/A 84 (25.07.14).
17 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: DE LA FUENTE ELVIRA BERNARDO. Datos registrales. T 29498 , F 103, S 8, H M 74303, I/A 83 (9.06.14).
23 de Mayo de 2014Nombramientos. Apoderado: GAVIRA RUIZ MANUEL. Datos registrales. T 29498 , F 102, S 8, H M 74303, I/A 82 (13.05.14).
24 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO BECERRA JUAN. Datos registrales. T 29498 , F 102, S 8, H M 74303, I/A 81 (16.09.13).
03 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: MONSALVE CARCELEN RAFAEL FEDERICO. Datos registrales. T 29498 , F 101, S 8, H M 74303,I/A 80 (25.06.13).
08 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: ALCALDE ESPINAR JUAN. Datos registrales. T 29498 , F 100, S 8, H M 74303, I/A 79 (25.03.13).
09 de Octubre de 2012Cambio de domicilio social. C/ TEIDE 4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 29498 , F 100, S 8, H M 74303,I/A 78 (27.09.12).
05 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUPEREZ ASTARLOA MARGARITA. Datos registrales. T 26597 , F 179, S 8, H M 74303, I/A 76(23.02.12).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ BESCOS MARIA. Apo.Man.Soli: BAMBA CHAVARRIA FELIX ANGEL. Datos registrales.T 29498 , F 100, S 8, H M 74303, I/A 77 (23.02.12).
19 de Octubre de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO LUJAN JESUS. Datos registrales. T 26597 , F 175, S 8, H M 74303, I/A 73 ( 6.10.11).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MENDEZ VEGA ALBERTO. Datos registrales. T 26597 , F 177, S 8, H M 74303, I/A 74 ( 6.10.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ALONSO GONZALEZ MARIA-JESUS. Datos registrales. T 26597 , F 178, S 8, H M 74303, I/A 75 (6.10.11).
27 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ VILLA LISARDO. Datos registrales. T 26597 , F 174, S 8, H M 74303, I/A 72 (13.04.11).
21 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ FELIPE JOSE LUIS. Datos registrales. T 26597 , F 171, S 8, H M 74303, I/A 71 (8.02.11).
09 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE LAS HERAS CARLOS. Datos registrales. T 26597 , F 170, S 8, H M 74303, I/A 70(27.05.10).
08 de Abril de 2010Revocaciones. Apoderado: PEREZ CHIRINOS PEREZ ROBERTO. Datos registrales. T 26597 , F 9, S 8, H M 74303, I/A 69(26.03.10).
11 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEZ CALURANO JOAQUIN. Datos registrales. T 26597 , F 7, S 8, H M 74303, I/A 68 (26.02.10).
10 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: SIEVERS BARRABINO FRANCISCO. Datos registrales. T 26597 , F 7, S 8, H M 74303, I/A 67(29.01.10).
17 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: HERNANDEZ APONTE JERONIMO. Apo.Manc.: HERNANDEZ APONTE JERONIMO. Datosregistrales. T 26597 , F 3, S 8, H M 74303, I/A 65 ( 7.07.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: SUILS FUENTES FRANCISCO. Apo.Sol.: SUILS FUENTES FRANCISCO. Datos registrales. T 26597, F 5, S 8, H M 74303, I/A 66 ( 7.07.09).
15 de Abril de 2009Nombramientos. Apoderado: SAN JOSE VAQUERO GERMAN. Datos registrales. T 19479 , F 179, S 8, H M 74303, I/A 63 (2.04.09).
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MARTINEZ RICARDO;CHAUSA GONZALEZ MANUEL;LASA DOLHAGARAYANTONIO;AYMERICH LARREY FRANCISCO JOSE;RUIZ RICA JOSE. Datos registrales. T 26597 , F 2, S 8, H M 74303, I/A 64 (2.04.09).