Actos BORME de Sistral Autos Sl
24 de Noviembre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 697/2010. Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Revocaci贸n de administradoresconcursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. AdministradorConcursal. Fecha 30/09/2014, NIF/CIF 33801513T. RODRIGUEZ DOCAMPO ENRIQUE JESUS. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 635/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/09/2014. Auto de conclusi贸n del concurso. Inexistencia debienes. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: ALBERTO BENEITEZ ANTON. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 635/2010. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 30/09/2014. Cese de las limitaciones de las facultades deadministraci贸n. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: ALBERTO BENEITEZ ANTON. Extinci贸n.Datos registrales. T 405 , F 225, S 8, H LU 3595, I/A 27 (13.11.14).
23 de Julio de 2010Revocaciones. Apoderado: MOYA MENDIETA MARTIN. Apo.Manc.: APARICIO DESIDERIO ANA;MOYA MENDIETA MARTIN.Datos registrales. T 405 , F 224, S 8, H LU 3595, I/A 26 (10.07.10).
02 de Julio de 2010Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 697/2010. Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. Administrador Concursal.Fecha 1/06/2010, NIF/CIF 33801513T. RODRIGUEZ DOCAMPO ENRIQUE JESUS. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal697/2010. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Auto de declaraci贸n de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 697/2010.FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 1/06/2010. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸ny disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE 1& INSTANCIA Y MERCANTIL. Juez: AURELIA BELLO FERNANDEZ.Datos registrales. T 405 , F 224, S 8, H LU 3595, I/A A (21.06.10).
14 de Abril de 2010Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ BARCIA RAMON. Datos registrales. T 405 , F 223, S 8, H LU 3595, I/A 24 (29.03.10).
23 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: AUDITORES CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES SR. Datos registrales. T 405 , F 223, S 8,H LU 3595, I/A 23 (10.02.10).
25 de Marzo de 2009Nombramientos. Apoderado: MOYA MENDIETA MARTIN. Datos registrales. T 405 , F 221, S 8, H LU 3595, I/A 19 (10.03.09).
Nombramientos. Apoderado: APARICIO DESIDERIO ANA. Datos registrales. T 405 , F 221, S 8, H LU 3595, I/A 20 (10.03.09).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ BARCIA RAMON. Datos registrales. T 405 , F 222, S 8, H LU 3595, I/A 21 (10.03.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: APARICIO DESIDERIO ANA;MOYA MENDIETA MARTIN. Datos registrales. T 405 , F 223, S 8, H LU3595, I/A 22 (10.03.09).
26 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARCIA RAMON. Apo.Man.Soli: SAEZ ABUIN JOSE MANUEL;NU脩EZ GONZALEZ JOSELUIS. Datos registrales. T 405 , F 221, S 8, H LU 3595, I/A 15 (12.02.09).
12 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: CARIDE CORTIZO JOSE. Consejero: CARIDE CORTIZO JOSE. Cons.Del.Sol: CARIDE CORTIZOJOSE. Consejero: CARIDE PUENTE ANDRES;IGLESIAS VAZQUEZ ANTONIO;CARIDE PUENTE JUAN CARLOS. Secretario:CARIDE PUENTE JUAN CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO MOYVESA SL. Modificaciones estatutarias. Cambiodel Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 259 , F 203, S 8, H LU 3595, I/A17 (30.01.09).