Actos BORME de Sivicom Systems Sl
18 de Diciembre de 2023Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO. Datos registrales. T 34896 , F 158, S 8, H B253927, I/A A ( 5.12.23).
25 de Julio de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: MOLINA MURCIA FRANCISCA. Datos registrales. T 34896 , F 158, S 8, H B 253927, I/A 10(13.07.17).
22 de Mayo de 2017Revocaciones. AUDIT.CUENT.: ABL AUDITORES SL. Datos registrales. T 34896 , F 158, S 8, H B 253927, I/A 9 (10.05.17).
27 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 116.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 120.000,00 Euros. Datos registrales. T 34896 , F 157, S 8,H B 253927, I/A 8 (19.05.15).
14 de Mayo de 2015Nombramientos. AUDIT.CUENT.: ABL AUDITORES SL. Datos registrales. T 34896 , F 157, S 8, H B 253927, I/A 7 ( 6.05.15).
05 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Cambio dedomicilio social. AV CERDANYOLA NUM.92 P.2 OFICINA 28 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datos registrales. T 34896 , F 156, S8, H B 253927, I/A 6 (28.01.13).
31 de Agosto de 2011Revocaciones. ADMINISTR.: VALLS ADAM XAVIER. Nombramientos. ADM.UNICO: CELDRAN LOPEZ JOSE LUIS. Datosregistrales. T 34896 , F 154, S 8, H B 253927, I/A 4 (19.08.11).
Nombramientos. APODERADO: DEL AGUILA SOLA OLGA. Datos registrales. T 34896 , F 154, S 8, H B 253927, I/A 5 (19.08.11).
09 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. AV CORTS CATALANES NUM.9 EDIF.TRADE CENTER III P.2 (SANT CUGAT DEL VALLES). Datosregistrales. T 34896 , F 153, S 8, H B 253927, I/A 3 (27.05.10).