Buscador CIF Logo

Actos BORME Smithkline Beecham Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Smithkline Beecham Sa

Actos BORME Smithkline Beecham Sa - A28490407

Tenemos registrados 67 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Smithkline Beecham Sa con CIF A28490407

🔙 Perfil de Smithkline Beecham Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Smithkline Beecham Sa

30 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: CEJAS CORDON ANTONIO. Datos registrales. T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 249 (23.05.23).

17 de Febrero de 2023
Otros conceptos: Cambio del domicilio del socio único y cambio de denominación del mismo pasando de GLAXOSMITHKLINECONSUMER HEALTHCARE(OVERSEAS) LIMITED a denominarese HALEONUK SERVICESLIMITED en virtud de acuerdo de fecha18 de noviembre de 2022. Datos registrales. T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 248 (10.02.23).

02 de Febrero de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36320 , F 19, S 8, H M 120046, I/A 247 (26.01.23).

12 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTIN ENRIC ALEJANDRO;GOLEN DAGMARA DANUTA;TOMALAC KATARZYNAMARIA. Datos registrales. T 36320 , F 18, S 8, H M 120046, I/A 246 ( 1.12.22).

23 de Agosto de 2022
Reelecciones. Consejero: BITZER MARCUS. Datos registrales. T 36320 , F 16, S 8, H M 120046, I/A 244 (16.08.22).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ GONZALEZ CRISTINA. Apo.Sol.: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETOJOSEFA;REDONDO NIETO JULIAN. Apoderado: GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO;MARIN GALLARDO CONCEPCIONJULIA;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: MUÑOZ DIAZALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: VIERA GUTIERREZ FATIMA. Apo.Sol.: GARCIA GAZO LUISDAMIAN. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO;RAMIREZ JUSTO MOISES;MARIN GALLARDO CONCEPCION-JULIA;CASTRO RUIZ MARIA DEL CARMEN. Apo.Sol.: RAMIREZ JUSTO MOISES;DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO.Apoderado: FAUS HINDERSIN RAMON NICOLAU. Nombramientos. Apoderado: HUERTA PIEDRA ROSA MARIA. Datosregistrales. T 36320 , F 16, S 8, H M 120046, I/A 245 (16.08.22).

22 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: BOZENA LUKOMSKA VICTORIA;PINKOWSKA MALGORZATA KATARZYNA. Datos registrales. T36320 , F 15, S 8, H M 120046, I/A 243 (15.07.22).

26 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE FINANCE LIMITE. Datos registrales. T 36320 , F 15,S 8, H M 120046, I/A 242 (19.04.22).

27 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36320 , F 15, S 8, H M 120046, I/A 241 (20.10.21).

25 de Octubre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ PEÑA GARCIA TERESA. Nombramientos. Apoderado: BELLO CANEDO MARIA OLGA.Datos registrales. T 36320 , F 13, S 8, H M 120046, I/A 239 (18.10.21).

Reelecciones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ IÑIGO. Datos registrales. T 36320 , F 14, S 8, H M 120046, I/A 240 (18.10.21).

17 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTIN GALLARDO CONCEPCION-JULIA. Revocaciones. Apoderado: RECASENS MARIJAIME;RECASENS MARI JAIME. Nombramientos. SecreNoConsj: BELLO CANEDO MARIA OLGA. Datos registrales. T 36320 , F13, S 8, H M 120046, I/A 238 (10.02.21).

16 de Diciembre de 2020
Revocaciones. Apoderado: PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;PEREZ SANTOS JUAN MANUEL. Apo.Man.Soli: PEREZ SANTOSJUAN MANUEL. Apoderado: MARTIN CANDAU CAYETANO. Datos registrales. T 36320 , F 12, S 8, H M 120046, I/A 237 ( 9.12.20).

22 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANAU TORRECILLA ADELA. Presidente: SANAU TORRECILLA ADELA. Revocaciones.Apoderado: SANAU TORRECILLA ADELA;SANAU TORRECILLA ADELA;SANAU TORRECILLA ADELA. Apo.Manc.: SANAUTORRECILLA ADELA. Apo.Sol.: SANAU TORRECILLA ADELA. Apo.Man.Soli: SANAU TORRECILLA ADELA. Nombramientos.Consejero: AMAYA GONZALEZ LUZ DARY. Presidente: AMAYA GONZALEZ LUZ DARY. Apoderado: AMAYA GONZALEZ LUZDARY. Datos registrales. T 36320 , F 9, S 8, H M 120046, I/A 235 (15.10.20).

Nombramientos. Apoderado: FAUS HINDERSIN RAMON NICOLAU. Datos registrales. T 36320 , F 11, S 8, H M 120046, I/A 236(15.10.20).

19 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GONZALEZ IÑIGO. Apo.Manc.: BITZER MARCUS. Datos registrales. T 36320 , F 8, S 8, HM 120046, I/A 234 ( 9.10.20).

10 de Julio de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ-OLLEROS ESCANDELL MARTA. Nombramientos. Apoderado: BITZER MARCUS. Datosregistrales. T 36320 , F 8, S 8, H M 120046, I/A 233 ( 3.07.20).

23 de Diciembre de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: CABALLERO ESPINOZA GONZALO ALFONSO. Apo.Man.Soli: DE LOS MOZOS CUADRADO JOSEISMAEL;CUESTA CIRBIAN RUBEN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANAU TORRECILLA ADELA;LOPEZ GONZALEZIÑIGO;BITZER MARCUS. Apo.Manc.: VERDEJO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE;VELO BRUNET SANDRINE AGNES. Apo.Sol.:SANCHEZ BARAJAS MARIA TERESA;FERNANDEZ PEÑA GARCIA TERESA;POMBO MUNILLA MIKEL;PEREZ-OLLEROSESCANDELL MARTA. Datos registrales. T 36320 , F 7, S 8, H M 120046, I/A 232 (16.12.19).

29 de Julio de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: DE LERA SANCHEZ MARCOS ANTONIO. Datos registrales. T 36320 , F 6, S 8, H M 120046, I/A 231(19.07.19).

20 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: CARRETERO FREITAS BEGOÑA;DIAZ GOMEZ MARIA ELISA. Nombramientos. Apo.Sol.: SANAUTORRECILLA ADELA;LOPEZ GONZALEZ IÑIGO;BITZER MARCUS;VERDEJO RODRIGUEZ ANTONIO JOSE. Otros conceptos:REVOCACION DEL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DOÑA MARIA ELISA DIAZ GOMEZ EN EL ACUERDO SEGUNDO,APARTADOS A, B Y C Y EL ACUERDO TERCERO DE LA INSCRIPCION 184ª. Datos registrales. T 36320 , F 5, S 8, H M 120046,I/A 230 (13.06.19).

04 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: MORALES MENENDEZ EVA. Nombramientos. Apo.Sol.: RAMIREZ JUSTO MOISES. Datosregistrales. T 36320 , F 4, S 8, H M 120046, I/A 228 (28.01.19).

Modificaciones estatutarias. Artículo 20º.- Convocatoria y quorum de las reuniones del Consejo. Datos registrales. T 36320 , F 4, S8, H M 120046, I/A 229 (28.01.19).

14 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: CALLEJA MERINO MARIANO. Nombramientos. Apoderado: CASTRO RUIZ MARIA DEL CARMEN.Datos registrales. T 36320 , F 3, S 8, H M 120046, I/A 227 ( 7.11.18).

18 de Octubre de 2018
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 36320 , F 3, S 8, H M 120046, I/A 226 ( 9.10.18).

16 de Febrero de 2018
Revocaciones. Apoderado: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL;COLLDEFORSMARTINEZ JOSE MIGUEL. Apo.Man.Soli: LUCAS SANCHEZ MARIA JOSE. Apo.Manc.: GAITAN GARZA ALEJANDRO.Nombramientos. Apoderado: RAMIREZ JUSTO MOISES;MARTIN CANDAU CAYETANO;MARIN GALLARDO CONCEPCION-JULIA.Datos registrales. T 36320 , F 1, S 8, H M 120046, I/A 225 ( 9.02.18).

04 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LOS MOZOS CUADRADO JOSE ISMAEL. Secretario: COLLDEFORS MARTINEZ JOSE MIGUEL.Nombramientos. Consejero: BITZER MARCUS. SecreNoConsj: MARTIN GALLARDO CONCEPCION-JULIA. Reelecciones.Consejero: SANAU TORRECILLA ADELA. Presidente: SANAU TORRECILLA ADELA. Datos registrales. T 17394 , F 209, S 8, H M120046, I/A 223 (28.08.17).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 36320 , F 1, S 8, H M 120046, I/A224 (28.08.17).

01 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: LOBO GARCIA SANTIAGO;FERRE REVUELTA MERCEDES;FERRE REVUELTA MERCEDES. Datosregistrales. T 17394 , F 209, S 8, H M 120046, I/A 222 (24.07.17).

11 de Noviembre de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 209, S 8, H M 120046,I/A 221 ( 3.11.16).

31 de Agosto de 2016
Reelecciones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ IÑIGO;DE LOS MOZOS CUADRADO JOSE ISMAEL. Datos registrales. T 17394 , F208, S 8, H M 120046, I/A 220 (23.08.16).

13 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: PARIS VICENTE GONZALO;PARIS VICENTE GONZALO;PARIS VICENTE GONZALO.Nombramientos. Apoderado: DE JUAN ECHAVARRI GUILLERMO. Datos registrales. T 17394 , F 208, S 8, H M 120046, I/A 219 (6.06.16).

21 de Enero de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: GAITAN GARZA ALEJANDRO. Apo.Man.Soli: PEREZ SANTOS JUAN MANUEL;DIAZ GOMEZ MARIAELISA;MORALES MENENDEZ EVA;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: LUCASSANCHEZ MARIA JOSE;VIERA GUTIERREZ FATIMA. Apo.Man.Soli: CUESTA CIRBIAN RUBEN. Apo.Manc.: CALLEJA MERINOMARIANO;LOBO GARCIA SANTIAGO;SANAU TORRECILLA ADELA;DE LOS MOZOS CUADRADO JOSE ISMAEL. Datosregistrales. T 17394 , F 206, S 8, H M 120046, I/A 218 (14.01.16).

29 de Octubre de 2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 206, S 8, H M 120046,I/A 217 (22.10.15).

12 de Agosto de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: PEINADO ALFAGEME RAFAEL. Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA GAZO LUIS DAMIAN. Datosregistrales. T 17394 , F 206, S 8, H M 120046, I/A 216 ( 3.08.15).

30 de Abril de 2015
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE (OVERSEAS)LIM. Datos registrales. T 17394 , F 206, S 8, H M 120046, I/A 215 (22.04.15).

21 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: MULTIGESTION IBERIA SOCIEDAD ANONIMA. Nombramientos. Apoderado: MULTIGESTIONIBERIA 2014 SL. Datos registrales. T 17394 , F 204, S 8, H M 120046, I/A 213 (13.04.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUCAS SANCHEZ MARIA JOSE;VIERA GUTIERREZ FATIMA. Datos registrales. T 17394 , F 205,S 8, H M 120046, I/A 214 (13.04.15).

22 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 204, S 8, H M 120046,I/A 211 (12.12.14).

Revocaciones. Apoderado: CALVO ALONSO DANIEL. Apo.Sol.: CALVO ALONSO DANIEL. Nombramientos. Apoderado: FERREREVUELTA MERCEDES;CEJAS CORDON ANTONIO;SANAU TORRECILLA ADELA. Datos registrales. T 17394 , F 204, S 8, H M120046, I/A 212 (12.12.14).

17 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: BECKER RUDIGER. Nombramientos. Apoderado: RECASENS MARI JAIME. Datos registrales. T17394 , F 203, S 8, H M 120046, I/A 210 ( 9.06.14).

07 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 203, S 8, H M 120046,I/A 208 (26.12.13).

Revocaciones. Apoderado: CASTELLANOS GRACIA LUIS. Nombramientos. Apo.Manc.: MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZFRANCO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 17394 , F 203, S 8, H M 120046, I/A 209 (26.12.13).

30 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apoderado: PASCUAL GARCIA LUIS. Datos registrales. T 17394 , F 202, S 8, H M 120046, I/A 207 (22.10.13).

20 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ACHA ROMEO NATALIA. Nombramientos. Apoderado: RECASENS MARI JAIME. Datosregistrales. T 17394 , F 202, S 8, H M 120046, I/A 206 (12.08.13).

01 de Julio de 2013
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ FERNANDEZ CONSUELO;GOMEZ FERNANDEZ CONSUELO. Nombramientos. Apoderado:MUÑOZ DIAZ ALFONSO;MUÑOZ DIAZ ALFONSO;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCO JAVIER;VAZQUEZ FRANCO FRANCISCOJAVIER. Datos registrales. T 17394 , F 201, S 8, H M 120046, I/A 205 (21.06.13).

24 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MARISCAL MIGUEL JUAN CARLOS;SABATER RAMOS CARMEN MARIA. Nombramientos.Apoderado: HUERTA PIEDRA ROSA MARIA. Datos registrales. T 17394 , F 200, S 8, H M 120046, I/A 204 (16.01.13).

30 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 200, S 8, H M 120046,I/A 203 (18.10.12).

23 de Agosto de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ACHA ROMEO NATALIA. Datos registrales. T 17394 , F 199, S 8, H M 120046, I/A 202 (13.08.12).

10 de Agosto de 2012
Reelecciones. Consejero: SANAU TORRECILLA ADELA. Presidente: SANAU TORRECILLA ADELA. Datos registrales. T 17394 , F199, S 8, H M 120046, I/A 201 (17.07.12).

11 de Julio de 2012
Nombramientos. Apoderado: MULTIGESTION IBERIA SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 17394 , F 199, S 8, H M120046, I/A 200 (28.06.12).

07 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: DEL VALLE ALVAREZ ELOINA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LOS MOZOS CUADRADO JOSEISMAEL. Datos registrales. T 17394 , F 198, S 8, H M 120046, I/A 199 (23.02.12).

05 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL VALLE ALVAREZ ELOINA. Nombramientos. Consejero: DE LOS MOZOS CUADRADO JOSEISMAEL. Datos registrales. T 17394 , F 198, S 8, H M 120046, I/A 198 (22.02.12).

13 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 197, S 8, H M 120046,I/A 197 (30.11.11).

07 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Consejero: LOPEZ GONZALEZ IÑIGO. Datos registrales. T 17394 , F 196, S 8, H M 120046, I/A 195 (10.08.11).

Revocaciones. Apo.Sol.: MUÑOZ FUENTES JORGE. Apoderado: MUÑOZ FUENTES JORGE. Nombramientos. Apoderado:GARCIA-SOTO RETUERTA ROBERTO;MARIN GALLARDO CONCEPCION JULIA. Datos registrales. T 17394 , F 197, S 8, H M120046, I/A 196 (10.08.11).

15 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: SABATER RAMOS CARMEN MARIA. Datos registrales. T 17394 , F 194, S 8, H M 120046, I/A 193 (2.03.11).

Revocaciones. Apoderado: PORTAL MARTINEZ PERFECTO;PORTAL MARTINEZ PERFECTO. Nombramientos. Apoderado:MORALES MENENDEZ EVA. Datos registrales. T 17394 , F 195, S 8, H M 120046, I/A 194 ( 3.03.11).

10 de Diciembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: CARDONIGA MAO JOSE;TARRIZA MARTINEZ JOSE;CADORNIGA MAO JOSE. Apo.Sol.: TARRIZAMARTINEZ JOSE. Datos registrales. T 17394 , F 194, S 8, H M 120046, I/A 192 (26.11.10).

01 de Diciembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 194, S 8, H M 120046,I/A 191 (19.11.10).

10 de Noviembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ DUARTE PILAR. Apo.Manc.: GOMEZ DUARTE PILAR. Apoderado: GOMEZ DUARTE PILAR.Datos registrales. T 17394 , F 193, S 8, H M 120046, I/A 190 (28.10.10).

14 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: CHILVER-STAINER SARAH JANE. Datos registrales. T 17394 , F 193, S 8, H M 120046, I/A 189(30.09.10).

06 de Agosto de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL;DE PRADO GARCIA SUSANA. Nombramientos. Apoderado: FERREREVUELTA MERCEDES. Datos registrales. T 17394 , F 192, S 8, H M 120046, I/A 188 (27.07.10).

29 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTIN BOADO ANA MARIA. Datos registrales. T 17394 , F 192, S 8, H M 120046, I/A 187 (16.03.10).

05 de Enero de 2010
Revocaciones. Apoderado: DAL-RE SAAVEDRA RAFAEL. Datos registrales. T 17394 , F 192, S 8, H M 120046, I/A 186 (22.12.09).

23 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 17394 , F 192, S 8, H M 120046,I/A 185 (11.11.09).

26 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apoderado: FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERRERO LOPEZ RAFAEL;FERRERO LOPEZ RAFAEL;LUZ MORENOJUAN PEDRO. Nombramientos. Apoderado: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;GOMEZ FERNANDEZ CONSUELO;DIAZ GOMEZ MARIAELISA. Datos registrales. T 17394 , F 191, S 8, H M 120046, I/A 184 (14.10.09).

02 de Julio de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ GOMEZ MARIA ELISA;JIMENEZ COLETO JOSEFA;DE PRADO GARCIA SUSANA;CALVOALONSO DANIEL;TARRIZA MARTINEZ JOSE;REDONDO NIETO JULIAN. Datos registrales. T 17394 , F 191, S 8, H M 120046, I/A183 (23.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información