Buscador CIF Logo

Actos BORME Socibus Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Socibus Sa

Actos BORME Socibus Sa - A80098734

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Socibus Sa con CIF A80098734

馃敊 Perfil de Socibus Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Socibus Sa

09 de Mayo de 2023
Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8, H M27514, I/A 44 ( 1.05.23).

17 de Enero de 2022
Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8, H M 27514, I/A 42 (10.01.22).

Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8,H M 27514, I/A 43 (10.01.22).

27 de Mayo de 2020
Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUAN YPASCUAL ANGEL. Co.De.Ma.So: NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUAN Y PASCUAL ANGEL;VERA SOLER JOSE. Consejero:ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Secretario: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Cons.Del.Man: ROMERO GARCIAFAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 223, S 8, H M 27514, I/A 41 (21.05.20).

03 de Enero de 2020
Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 1486 , F 223, S 8, H M27514, I/A 40 (26.12.19).

11 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MORA RAFAEL. Datos registrales. T 1486 , F 222, S 8, H M 27514, I/A 39 ( 4.06.19).

21 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 1486 , F 222, S 8, H M 27514, I/A 38(14.02.19).

06 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 1486 , F 222, S8, H M 27514, I/A 37 (27.03.18).

21 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 1486 , F 221, S 8, H M 27514, I/A 36(14.12.17).

26 de Julio de 2017
Nombramientos. Apoderado: ORDAS MATAS VICTOR. Datos registrales. T 1486 , F 220, S 8, H M 27514, I/A 34 (18.07.17).

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 221, S 8, H M 27514,I/A 35 (18.07.17).

03 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Consejero: ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Co.De.Ma.So:ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Nombramientos. Consejero: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Secretario: ROMERO GARCIAFAUSTINO JESUS. Cons.Del.Man: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 220, S 8, H M 27514, I/A 33(24.02.17).

19 de Enero de 2017
Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 1486 , F 220, S8, H M 27514, I/A 32 (11.01.17).

10 de Agosto de 2016
Ampliacion del objeto social. EL TRANSPORTE TANTO DE MERCANCIAS COMO VIAJEROS, CUALQUIER MODO Y MEDIO DETRANSPORTE (TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO)... Datos registrales. T 1486 , F 219, S 8, H M 27514, I/A 31 (2.08.16).

28 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 1486 , F 219, S 8, H M 27514, I/A 30 (17.03.16).

16 de Febrero de 2015
Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Co.De.Ma.So: ROMERO GOMEZ FAUSTINO;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUANY PASCUAL ANGEL;VERA SOLER JOSE. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 218,S 8, H M 27514, I/A 29 ( 5.02.15).

15 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: L R A AUDITORES SL. Datos registrales. T 1486 , F 218, S 8, H M 27514, I/A 28 ( 7.10.14).

31 de Julio de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto.- Ampliaci贸n del Objeto social.. Ampliacion del objeto social. Laexplotaci贸n del transporte por ferrocarril de viajeros, mercanc铆as o mixto, con medios propios o ajenos, ya sean p煤blicos o privados, enlos 谩mbitos urbano, interurbano o internacional, en cualquiera de las modalidades reguladas por la legislaci贸n ordenadora deltransporte terrestre... Datos registrales. T 1486 , F 218, S 8, H M 27514, I/A 27 (24.07.14).

27 de Marzo de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 165.275,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.337.225,00 Euros. Datos registrales. T 1486 , F217, S 8, H M 27514, I/A 26 (15.03.13).

18 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 1486 , F 217, S 8, H M 27514, I/A 24 (3.04.12).

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 217, S 8, H M27514, I/A 25 ( 3.04.12).

03 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apoderado: PEREZ PITA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 216, S 8, H M 27514, I/A 22 (24.01.12).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 1486 , F 216, S 8, H M 27514, I/A 23(24.01.12).

06 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: PEREZ PITA JOSE LUIS CARLOS. Datos registrales. T 1486 , F 215, S 8, H M 27514, I/A 21(25.04.11).

15 de Marzo de 2011
Nombramientos. Auditor: L R A AUDITORES SL. Datos registrales. T 1486 , F 215, S 8, H M 27514, I/A 20 ( 3.03.11).

05 de Marzo de 2010
Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Cons.Del.Man: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Cons.Del.Sol: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 ,F 215, S 8, H M 27514, I/A 19 (23.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n