Actos BORME de Socibus Sa
09 de Mayo de 2023Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8, H M27514, I/A 44 ( 1.05.23).
17 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8, H M 27514, I/A 42 (10.01.22).
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 42889 , F 40, S 8,H M 27514, I/A 43 (10.01.22).
27 de Mayo de 2020Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUAN YPASCUAL ANGEL. Co.De.Ma.So: NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUAN Y PASCUAL ANGEL;VERA SOLER JOSE. Consejero:ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Secretario: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Cons.Del.Man: ROMERO GARCIAFAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 223, S 8, H M 27514, I/A 41 (21.05.20).
03 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 1486 , F 223, S 8, H M27514, I/A 40 (26.12.19).
11 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DELGADO MORA RAFAEL. Datos registrales. T 1486 , F 222, S 8, H M 27514, I/A 39 ( 4.06.19).
21 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 1486 , F 222, S 8, H M 27514, I/A 38(14.02.19).
06 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 1486 , F 222, S8, H M 27514, I/A 37 (27.03.18).
21 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 1486 , F 221, S 8, H M 27514, I/A 36(14.12.17).
26 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: ORDAS MATAS VICTOR. Datos registrales. T 1486 , F 220, S 8, H M 27514, I/A 34 (18.07.17).
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 221, S 8, H M 27514,I/A 35 (18.07.17).
03 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Consejero: ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Co.De.Ma.So:ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Nombramientos. Consejero: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Secretario: ROMERO GARCIAFAUSTINO JESUS. Cons.Del.Man: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 220, S 8, H M 27514, I/A 33(24.02.17).
19 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 1486 , F 220, S8, H M 27514, I/A 32 (11.01.17).
10 de Agosto de 2016Ampliacion del objeto social. EL TRANSPORTE TANTO DE MERCANCIAS COMO VIAJEROS, CUALQUIER MODO Y MEDIO DETRANSPORTE (TERRESTRE, MARITIMO, FLUVIAL Y AEREO)... Datos registrales. T 1486 , F 219, S 8, H M 27514, I/A 31 (2.08.16).
28 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 1486 , F 219, S 8, H M 27514, I/A 30 (17.03.16).
16 de Febrero de 2015Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Co.De.Ma.So: ROMERO GOMEZ FAUSTINO;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;JUANY PASCUAL ANGEL;VERA SOLER JOSE. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 , F 218,S 8, H M 27514, I/A 29 ( 5.02.15).
15 de Octubre de 2014Reelecciones. Auditor: L R A AUDITORES SL. Datos registrales. T 1486 , F 218, S 8, H M 27514, I/A 28 ( 7.10.14).
31 de Julio de 2014Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Objeto.- Ampliaci贸n del Objeto social.. Ampliacion del objeto social. Laexplotaci贸n del transporte por ferrocarril de viajeros, mercanc铆as o mixto, con medios propios o ajenos, ya sean p煤blicos o privados, enlos 谩mbitos urbano, interurbano o internacional, en cualquiera de las modalidades reguladas por la legislaci贸n ordenadora deltransporte terrestre... Datos registrales. T 1486 , F 218, S 8, H M 27514, I/A 27 (24.07.14).
27 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 165.275,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.337.225,00 Euros. Datos registrales. T 1486 , F217, S 8, H M 27514, I/A 26 (15.03.13).
18 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 1486 , F 217, S 8, H M 27514, I/A 24 (3.04.12).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 217, S 8, H M27514, I/A 25 ( 3.04.12).
03 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: PEREZ PITA JOSE LUIS. Datos registrales. T 1486 , F 216, S 8, H M 27514, I/A 22 (24.01.12).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 1486 , F 216, S 8, H M 27514, I/A 23(24.01.12).
06 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: PEREZ PITA JOSE LUIS CARLOS. Datos registrales. T 1486 , F 215, S 8, H M 27514, I/A 21(25.04.11).
15 de Marzo de 2011Nombramientos. Auditor: L R A AUDITORES SL. Datos registrales. T 1486 , F 215, S 8, H M 27514, I/A 20 ( 3.03.11).
05 de Marzo de 2010Reelecciones. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Consejero: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Cons.Del.Man: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. Cons.Del.Sol: VERA SOLER JOSE;NAJERA PASCUAL JOSE LUIS;ROMEROGOMEZ FAUSTINO;JUAN Y PASCUAL ANGEL. SecreNoConsj: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 1486 ,F 215, S 8, H M 27514, I/A 19 (23.02.10).