Actos BORME de Sociedad Anonima Comercial De Pescados Y Mariscos Peixemar
22 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: REY FIGUEROA FRANCISCO. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 92, S 8, H PO 28178, I/A 32(10.11.23).
12 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BOTASPESCA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2611,L 2611, F 92, S 8, H PO 28178, I/A 31 ( 3.11.21).
26 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS. Apo.Manc.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS. Apo.Sol.: FERNANDEZ VAZQUEZCARLOS. Apo.Manc.: MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Apoderado: MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 91,S 8, H PO 28178, I/A 29 (17.03.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ VARELA ANGEL;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS;FERNANDEZ RIVEIROLUIS;MOSQUERA RUIZ ADRIAN;MOSQUERA RUIZ DAVID. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 91, S 8, H PO 28178, I/A 30(17.03.21).
25 de Noviembre de 2020Reelecciones. Adm. Unico: BRUNET GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 91, S 8, H PO 28178, I/A 28(17.11.20).
20 de Octubre de 2020Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T2611, L 2611, F 91, S 8, H PO 28178, I/A 27 ( 9.10.20).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apoderado: MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 90, S 8, H PO 28178, I/A 26(14.08.20).
27 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ ANA ISABEL. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 89, S 8, H PO 28178, I/A25 (18.05.20).
29 de Julio de 2019Revocaciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORESSLP. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 89, S 8, H PO 28178, I/A 24 (18.07.19).
27 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VARELA ANGEL. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 89, S 8, H PO 28178, I/A 23(19.10.17).
13 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 88, S 8, H PO28178, I/A 22 ( 5.06.17).
27 de Enero de 2016Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ARMADORA VIBO SL. MERCAMARINUS SL. Datos registrales. T 2611, L 2611, F87, S 8, H PO 28178, I/A 21 (15.01.16).
18 de Diciembre de 2015Reelecciones. Adm. Unico: BRUNET GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 87, S 8, H PO 28178, I/A 20(10.12.15).
17 de Marzo de 2014Revocaciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 87, S 8, H PO 28178, I/A 18 (10.03.14).
Nombramientos. Auditor: NORAUDIT AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 87, S 8, H PO28178, I/A 19 (10.03.14).
10 de Marzo de 2014Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS;MOSQUERA RUIZ ADRIAN. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 87, S8, H PO 28178, I/A 17 (28.02.14).
12 de Abril de 2013Reelecciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 86, S 8, H PO 28178, I/A 16 ( 4.04.13).
30 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RIVEIRO LUIS;FERNANDEZ VAZQUEZ CARLOS. Datos registrales. T 2611, L 2611, F86, S 8, H PO 28178, I/A 15 (18.05.11).
07 de Marzo de 2011Reelecciones. Adm. Unico: BRUNET GARCIA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 86, S 8, H PO 28178, I/A 14(21.02.11).
12 de Enero de 2009Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: NOSTRUMAUDITORES SL. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 85, S 8, H PO 28178, I/A 12 (23.12.08).
Reelecciones. Auditor: NOSTRUM AUDITORES SL. Datos registrales. T 2611, L 2611, F 86, S 8, H PO 28178, I/A 13 (23.12.08).