Actos BORME de Sociedad Anonima De Comerciantes De Recambios De Automoviles
11 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 224, S 8, H M 13719,I/A 47 (30.11.23).
17 de Noviembre de 2022Nombramientos. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 223, S 8, H M 13719,I/A 46 ( 8.11.22).
13 de Agosto de 2021Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 223, S 8, H M 13719,I/A 45 ( 8.08.21).
22 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 223, S 8, H M 13719,I/A 44 (15.10.20).
15 de Septiembre de 2020Nombramientos. Consejero: DE LA PE脩A ITURRIAGA MANUEL. Reelecciones. Consejero: JOSE PORRAS SAEZ;ALBACETEPEREA ALFONSO ENRIQUE;MARTINEZ DIEGO ANTONIO;GALLARDO GONZALEZ MARCELINO FELIX. Presidente: PORRASSAEZ JOSE. Vicepresid.: ALBACETE PEREA ALFONSO ENRIQUE. Co.De.Ma.So: ALBACETE PEREA ALFONSOENRIQUE;MARTINEZ DIEGO ANTONIO. Secretario: LOBO DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE. Modificaciones estatutarias.Introducci贸n de los nuevos articulos 16 bis y 20 bis de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 12560 , F 222, S 8, H M 13719, I/A43 ( 8.09.20).
08 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 222, S 8, H M 13719,I/A 42 ( 1.10.19).
13 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 222, S 8, H M 13719,I/A 41 ( 5.11.18).
04 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 221, S 8, H M 13719,I/A 40 (24.11.17).
08 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 35.819,60 Euros. Resultante Suscrito: 472.866,80 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: ARTICULO 5.- . Datos registrales. T 12560 , F 221, S 8, H M 13719, I/A 39 (31.01.17).
04 de Noviembre de 2016Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 220, S 8, H M 13719,I/A 38 (26.10.16).
05 de Agosto de 2015Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 220, S 8, H M 13719,I/A 37 (28.07.15).
03 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DAVA SA;GERSTENMAIER SA;REPUESTOS MONTERO SL. Presidente: REPUESTOS MONTEROSL. Cons.Del.Man: REPUESTOS MONTERO SL;GERSTENMAIER SA;DAVA SA. Consejero: GALLARDO GONZALEZ MARCELINOFELIX;LOPEZ BRAVO ALBERTO TOMAS. Representan: ALBACETE PEREA ALFONSO ENRIQUE;PORRAS SAEZ JOSE;MARTINEZDIEGO ANTONIO. Nombramientos. Consejero: JOSE PORRAS SAEZ;ALBACETE PEREA ALFONSO ENRIQUE;MARTINEZDIEGO ANTONIO;GALLARDO GONZALEZ MARCELINO FELIX. Presidente: PORRAS SAEZ JOSE. Vicepresid.: ALBACETE PEREAALFONSO ENRIQUE. Co.De.Ma.So: ALBACETE PEREA ALFONSO ENRIQUE;MARTINEZ DIEGO ANTONIO. Reelecciones.Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Secretario: LOBO DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE. Datosregistrales. T 12560 , F 220, S 8, H M 13719, I/A 36 (26.01.15).
16 de Diciembre de 2013Nombramientos. Consejero: GALLARDO GONZALEZ MARCELINO FELIX. Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORESIBERICA SL PROFESIONAL. Otros conceptos: RATIFICACION DEL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO POR COOPTACIONDE DON ALBERTO TOMAS LOPEZ BRAVO. Datos registrales. T 12560 , F 219, S 8, H M 13719, I/A 35 ( 4.12.13).
14 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL;SANCHEZ CONDE ANTONIO. Cons.Del.Man: RODRIGUEZGUTIERREZ RAFAEL;SANCHEZ CONDE ANTONIO;REPUESTOS MONTERO SL. Vicepresid.: RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL.Consejero: FERNANDEZ HERRERO REYES;MAZUECOS ORTEGO PABLO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ BRAVOALBERTO TOMAS. Cons.Del.Man: REPUESTOS MONTERO SL;GERSTENMAIER SA;DAVA SA. Datos registrales. T 12560 , F219, S 8, H M 13719, I/A 34 ( 4.10.13).
03 de Octubre de 2012Nombramientos. Consejero: MAZUECOS ORTEGO PABLO. Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SLPROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 218, S 8, H M 13719, I/A 33 (22.09.12).
20 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: MAZUECOS REGIDOR PABLO. Consejero: MAZUECOS REGIDOR PABLO. Vicepresid.:FERNANDEZ HERRERO REYES. Nombramientos. Presidente: REPUESTOS MONTERO SL. Vicepresid.: RODRIGUEZGUTIERREZ RAFAEL. Datos registrales. T 12560 , F 218, S 8, H M 13719, I/A 32 ( 7.02.12).
03 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: HUSSON AUDITORES IBERICA SL PROFESIONAL. Datos registrales. T 12560 , F 218, S 8, H M 13719,I/A 31 (21.10.11).
11 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: VALERO CALVO LUIS FELIPE. Nombramientos. Representan: ALBACETE PEREA ALFONSOENRIQUE. Datos registrales. T 12560 , F 217, S 8, H M 13719, I/A 28 (30.03.11).
Ceses/Dimisiones. Representan: ALBACETE GARCIA JAVIER ANTONIO. Nombramientos. Representan: MARTINEZ DIEGOANTONIO. Datos registrales. T 12560 , F 217, S 8, H M 13719, I/A 29 (30.03.11).
Nombramientos. Apoderado: GALLARDO GONZALEZ MARCELINO FELIX. Datos registrales. T 12560 , F 218, S 8, H M 13719, I/A30 (31.03.11).
05 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ HERRERO REYES. Presidente: FERNANDEZ HERRERO REYES. Cons.Del.Sol:FERNANDEZ HERRERO REYES. Consejero: DIAZ LOPEZ ANTONIO;ARRIBAS MEJIAS MARIANO;PAMPANAS PAMPANASLUIS;REPUESTOS MONTERO SL. Vicepresid.: PAMPANAS PAMPANAS LUIS. Cons.Del.Sol: PAMPANAS PAMPANASLUIS;ARRIBAS MEJIAS MARIANO. Consejero: DISTRITEL COMUNICACIONES SA. Representan: ALBACETE GARCIA JAVIERANTONIO;PORRAS SAEZ JOSE. Nombramientos. Representan: ALBACETE GARCIA JAVIER ANTONIO. Consejero: MAZUECOS
30 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: PEREZ SANCHEZ ANGEL ALBERTO. Nombramientos. Representan: PORRAS SAEZ JOSE.Otros conceptos: ACUERDO DE CESE Y DESIGNACION DE REPRESENTANTE PERSONA FISICA, ADOPTADO POR LASOCIEDAD 'REPUESTOS MONTERO, S.L.', PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO DE CONSEJERADE LA COMPA脩IA 'SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIANTES DE RECAMBIOS DE AUTOMOVILES.'. Datos registrales. T 12560, F 216, S 8, H M 13719, I/A 26 (20.01.09).