Buscador CIF Logo

Actos BORME Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo

Actos BORME Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo - A47030150

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo con CIF A47030150

馃敊 Perfil de Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sociedad Anonima De Granallados Y Pinturas Automaticas Julio Crespo

28 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 210, S 8, H M 252006, I/A 40 (20.12.22).

07 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 209, S 8, H M 252006, I/A 39 (31.07.20).

16 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO;CRESPO VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN. Presidente: CRESPOAGUILOCHE JULIO. Secretario: CRESPO VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN. Con.Delegado: CRESPO AGUILOCHE JULIO.Consejero: CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS JULIO;CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL. Nombramientos.Consejero: CRESPO VILLALOBOS JULIO;CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL;LOPEZ VEGAANIBAL. Presidente: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Secretario: CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL. Con.Delegado: CRESPOVILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 28852 , F 209, S 8, H M 252006, I/A 38 ( 8.08.19).

05 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CRESPO VILLALOBOS MARTA. Datos registrales. T 28852 , F 208, S 8, H M 252006, I/A 37(28.11.17).

20 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 208, S 8, H M 252006, I/A 36 (13.02.17).

20 de Abril de 2016
Nombramientos. Con.Delegado: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Reelecciones. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO;CRESPOVILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS JULIO;CRESPO VILLALOBOS ANA ISABEL;CRESPO VILLALOBOS MARIA DELCARMEN. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Secretario: CRESPO VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN. Datos registrales.T 28852 , F 207, S 8, H M 252006, I/A 35 (12.04.16).

28 de Mayo de 2013
Cambio de objeto social. La construcci贸n, urbanizaci贸n, promoci贸n, venta, arrendamiento, administraci贸n y explotaci贸n de solares,viviendas, locales y centros comerciales.- Datos registrales. T 28852 , F 207, S 8, H M 252006, I/A 34 (17.05.13).

18 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 28852 , F 206, S 8, H M 252006, I/A 33 (10.01.13).

13 de Marzo de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRESPO VILLALOBOS JULIO. Apo.Manc.: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Datos registrales. T28852 , F 205, S 8, H M 252006, I/A 32 ( 1.03.12).

20 de Julio de 2011
Revocaciones. Apoderado: MC LOUGHLIN RICARDO-DANIEL;ACEITUNO RUIZ MARIA-TERESA. Datos registrales. T 20187 , F194, S 8, H M 252006, I/A 31 (11.07.11).

01 de Junio de 2011
Reelecciones. Consejero: CRESPO AGUILOCHE JULIO;CRESPO VILLALOBOS MARTA;CRESPO VILLALOBOS JULIO;CRESPOVILLALOBOS ANA ISABEL;CRESPO VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN. Presidente: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Secretario:CRESPO VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN. Cons.Del.Sol: CRESPO AGUILOCHE JULIO. Datos registrales. T 20187 , F 194, S8, H M 252006, I/A 30 (23.05.11).

28 de Abril de 2011
Revocaciones. Apoderado: CARRASCOSA COSO EDUARDO;CORDOVES VICENTE JOSE-BERISIMO. Datos registrales. T20187 , F 194, S 8, H M 252006, I/A 29 (13.04.11).

15 de Abril de 2011
Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 20187 , F 194, S 8, H M 252006, I/A 28 ( 5.04.11).

13 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Apoderado: RAMOS TRIALASO LAURA. Datos registrales. T 20187 , F 193, S 8, H M 252006, I/A 27 (26.11.10).

15 de Octubre de 2010
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ESCRIBANO EMILIO. Datos registrales. T 20187 , F 193, S 8, H M 252006, I/A 25 (1.10.10).

Cambio de domicilio social. AVDA DE MADRID NUMERO 16 - POLIGONO ALBRESA; CRTA (VALDEMORO). Datos registrales.T 20187 , F 193, S 8, H M 252006, I/A 26 ( 1.10.10).

06 de Abril de 2010
Revocaciones. Apoderado: PEREZ SOBRINO ADOLFO;PEREZ SOBRINO ADOLFO. Datos registrales. T 20187 , F 191, S 8, H M252006, I/A 22 (22.03.10).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ VEGA ANIBAL. Datos registrales. T 20187 , F 191, S 8, H M 252006, I/A 23 (22.03.10).

Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 20187 , F 192, S 8, H M 252006, I/A 24 (22.03.10).

15 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MC LOUGHLIN RICARDO-DANIEL;ACEITUNO RUIZ MARIA-TERESA. Datos registrales. T 20187 , F189, S 8, H M 252006, I/A 21 ( 2.12.09).

29 de Julio de 2009
Reelecciones. Auditor: M V AUDITORES SL. Datos registrales. T 20187 , F 189, S 8, H M 252006, I/A 20 (17.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n