Actos BORME de Sociedad Anonima De Talleres De Manipulacion De Papel
20 de Julio de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 44992 , F 3, S 8, H M 591926, I/A 22 (13.07.23).
05 de Abril de 2023Nombramientos. Apoderado: CHACON ALCALA JOAQUIN. Datos registrales. T 32879 , F 40, S 8, H M 591926, I/A 19 (29.03.23).
06 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 40, S 8, H M 591926, I/A 18 (29.09.22).
14 de Julio de 2022Revocaciones. Apoderado: HERRERO GALARZA JOSE RAMON. Datos registrales. T 32879 , F 39, S 8, H M 591926, I/A 17 (7.07.22).
30 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: HORNEDO MUGUIRO JOSE ANDRES. Apo.Man.Soli: APARICIO GUTIERREZ MARIA MILAGROS.Apoderado: HORNEDO MUGUIRO JOSE ANDRES. Apo.Man.Soli: APARICIO GUTIERREZ MARIA MILAGROS. Apoderado:ARECHAGA JIMENEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32879 , F 39, S 8, H M 591926, I/A 16 (23.06.22).
26 de Enero de 2022Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ IRIBARREN IKER. Datos registrales. T 32879 , F 38, S 8, H M 591926, I/A 15 (19.01.22).
05 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 38, S 8, H M 591926, I/A 14 (28.10.21).
25 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA FUENTE MOREIRO ANDRES. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALEJA ALONSO MARIALOURDES. Datos registrales. T 32879 , F 37, S 8, H M 591926, I/A 13 (18.10.21).
16 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 37, S 8, H M 591926, I/A 12 ( 8.10.20).
22 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 36, S 8, H M 591926, I/A 11 (15.01.20).
06 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZARAGUETA YOLDI MARIA DOLORES;ZARAGUETA YOLDI MARIA DOLORES. Datos registrales.T 32879 , F 36, S 8, H M 591926, I/A 10 (27.02.19).
24 de Septiembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 36, S 8, H M 591926, I/A 9 (17.09.18).
16 de Julio de 2018Reelecciones. Representan: BORREGON BAQUERO MARIO MANUEL. Adm. Unico: A G PRINT SL. Datos registrales. T 32879 , F36, S 8, H M 591926, I/A 8 ( 9.07.18).
31 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: ALCALDE BLANQUER JOSE LUIS;COLOMINA HUELMO JUAN MARCOS;GOÑI MASCARAQUEJOSE LUIS;RODRIGUEZ SANTIUSTE ISIDORO. Datos registrales. T 32879 , F 35, S 8, H M 591926, I/A 7 (24.05.18).
31 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 33, S 8, H M 591926, I/A 5 (23.08.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARAHONA GONZALEZ RAFAEL;BARAHONA GONZALEZ RAFAEL. Nombramientos. Apoderado:ARECHAGA JIMENEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32879 , F 34, S 8, H M 591926, I/A 6 (23.08.17).
26 de Junio de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32879 , F 33, S 8, H M 591926, I/A 4 (15.06.17).
28 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: HORNEDO MUGUIRO JOSE ANDRES. Apo.Man.Soli: DE LA FUENTE MOREIRO ANDRES;HERASMORALEJA MANUEL;APARICIO GUTIERREZ MARIA MILAGROS;OSTRA BELDARRAIN PAULA;BARAHONA GONZALEZRAFAEL;ZARAGUETA YOLDI MARIA DOLORES. Datos registrales. T 32879 , F 32, S 8, H M 591926, I/A 3 (20.07.15).
02 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ EMILIO VARGAS 18(MADRID). Página web de la sociedad. Modificación de la página web corporativa.Nueva página web: www.sam-manipulados.com.Datos registrales. T 32879 , F 31, S 8, H M 591926, I/A 2 (24.11.14).
25 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ GARCIA DIEGO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA FUENTE MOREIROANDRES;HERAS MORALEJA MANUEL. Datos registrales. T 2490 , F 212, S 8, H SS 10746, I/A 25 (12.02.14).
03 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Ampliación de capital. Suscrito: 497.017,50 Euros. Desembolsado: 497.017,50 Euros.Resultante Suscrito: 1.022.017,50 Euros. Resultante Desembolsado: 1.022.017,50 Euros. Otros conceptos: MODIFICACION DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. MANIPULACION DEL PAPEL Y SUS DERIVADOS, CARTON,PLASTICOS, TRANSFORMADOS, COMPLEMENTOS Y LA VENTA DE SUS PRODUCTOS. Fusión por absorción. Sociedadesabsorbidas: PACSA, PAPELERA DE CARRION SL. Datos registrales. T 2490 , F 208, S 8, H SS 10746, I/A 24 (24.01.14).
05 de Agosto de 2013Reelecciones. Adm. Unico: A G PRINT SL. Datos registrales. T 2490 , F 208, S 8, H SS 10746, I/A 23 (30.07.13).
Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre ModificacionesEstructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace público el hecho de haber insertado, el pasado 25 de julio de 2013, el ProyectoComún de Fusión de las sociedades"SOCIEDAD ANONIMA DE TALLERES DE MANIPULACION DE PAPEL" (Sociedad Absorbente) y"PACSA PAPELERA DEL CARRION, S.L." (Sociedad Absorbida), en la página (www.sam.sobres.com). Datos registrales. T 2490 , F208, S 8, H SS 10746, I/A 23 M (30.07.13).
18 de Enero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: APARICIO GUTIERREZ MARIA MILAGROS;OSTRA BELDARRAIN PAULA;BARAHONAGONZALEZ RAFAEL;ZARAGUETA YOLDI MARIA DOLORES. Datos registrales. T 2490 , F 207, S 8, H SS 10746, I/A 22 (10.01.13).
29 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL. Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 3º Y 18º DE LOSESTATUTOS SOCIALES, PARA INCLUIR LA PAGINA WEB CORPORATIVA Y PERMITIR LASNUEVAS FORMAS DECONVOCATORIAS PREVISTAS POR LA NUEVA LEY VIGENTE EN LA MATERIA, MEDIANTE ANUNCIO EN LA PAGINA WEB DELA SOCIEDAD. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.sam-sobres.com. Datos registrales. T2490 , F 206, S 8, H SS 10746, I/A 21 (18.10.12).
02 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL;MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 2490 , F 206, S 8, H SS10746, I/A 20 (20.12.11).
06 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: URAIN MENDIBURU JOSE MARIA. Nombramientos. Apoderado: HORNEDO MUGUIRO JOSEANDRES. Datos registrales. T 2490 , F 206, S 8, H SS 10746, I/A 19 (26.03.11).
18 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS AMS SL. Datos registrales. T 1544 , F 215, S 8, H SS 10746, I/A 18 ( 6.11.09).