Actos BORME de Sociedad Anonima Municipal Actuaciones Urbanas De Valencia
14 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: GIL JIMENEZ ANA MARIA. Gerente: GIL JIMENEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 5117, L 2425, F225, S 8, H V 16880, I/A 78 ( 6.11.23).
Ceses/Dimisiones. Gerente: AZNAR TRAVAL ALBERTO. Revocaciones. Apoderado: AZNAR TRAVAL ALBERTO. Datosregistrales. T 8058, L 5351, F 153, S 8, H V 16880, I/A 79 ( 6.11.23).
28 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: GOMEZ LOPEZ SANDRA. Vicepresid.: LOZANO LAZARO ISABEL. Consejero: CAMPILLOFERNANDEZ SERGI;LOZANO LAZARO ISABEL;GREZZI GIUSEPPE;GINER CORELL JUAN MANUEL;MUNDINA GOMEZCARLOS;GOMEZ LOPEZ SANDRA;VALIA COTANDA ELISA;GINER GRIMA FERNANDO;MONTA脩EZ VALENZUELA VICENTE.Nombramientos. Consejero: GINER CORELL JUAN MANUEL;CARBONELL AGUILAR JESUS;MORENO MAICAS JOSELUIS;ROBLES GALINDO CARMEN LUISA;CAMPILLO FERNANDEZ SERGI;GOMEZ LOPEZ SANDRA;HERRERO CAMILLERICECILIA CARMEN. Presidente: GINER CORELL JUAN MANUEL. Vicepresid.: CARBONELL AGUILAR JESUS. Datos registrales. T5117, L 2425, F 225, S 8, H V 16880, I/A 77 (22.09.23).
12 de Mayo de 2022Modificaciones estatutarias. Art铆culo 18. Lugar y tiempo de la celebraci贸n. . Art铆culo 27. Constituci贸n, reuniones y adopci贸n deacuerdos en el Consejo. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 224, S 8, H V 16880, I/A 76 ( 5.05.22).
19 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GOSALBEZ PAYA JOSE VICENTE. Nombramientos. Consejero: MONTA脩EZ VALENZUELAVICENTE. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 224, S 8, H V 16880, I/A 75 (12.11.21).
14 de Octubre de 2021Nombramientos. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 224, S 8, H V 16880, I/A 74 (5.10.21).
10 de Agosto de 2021Fe de erratas: Aparece en el envio 194 del a帽o 2019. Publicado en el Bolet铆n 194 de fecha 09/10/19 y referencia 04199532019. sepublic贸 erroneamente la fecha del nombramiento, siendo la correcta 23/07/2019. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 222, S 8, H V16880, I/A 69 ( 2.10.19).
Ceses/Dimisiones. Gerente: MARTINEZ RODA JOSE ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODA JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 5117, L 2425, F 223, S 8, H V 16880, I/A 72 ( 3.08.21).
Nombramientos. Gerente: AZNAR TRAVAL ALBERTO. Apoderado: AZNAR TRAVAL ALBERTO. Datos registrales. T 5117, L 2425,F 223, S 8, H V 16880, I/A 73 ( 3.08.21).
09 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: TELLO COMPANY GLORIA;GREZZI GIUSEPPE;SARRIA MORELL VICENT;OLIVER SANZMARIA;NOVO BELENGUER ALFONSO;MENDOZA SEGUI ALBERTO;GINER GRIMA FERNANDO. Presidente: SARRIA MORELLVICENT. Vicepresid.: GREZZI GIUSEPPE. Nombramientos. Consejero: CAMPILLO FERNANDEZ SERGI;LOZANO LAZAROISABEL;GREZZI GIUSEPPE;GINER CORELL JUAN;MUNDINA GOMEZ CARLOS;GOMEZ LOPEZ SANDRA;VALIA COTANDAELISA;GINER GRIMA FERNANDO;GOSALBEZ PAYA JOSE VICENTE. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 222, S 8, H V 16880,I/A 69 ( 2.10.19).
Nombramientos. Presidente: GOMEZ LOPEZ SANDRA. Vicepresid.: LOZANO LAZARO ISABEL. Datos registrales. T 5117, L2425, F 222, S 8, H V 16880, I/A 70 ( 2.10.19).
Ceses/Dimisiones. Secretario: GARCIA RABASA PEDRO. Nombramientos. Secretario: LATORRE HERNANDEZ MANUEL. Datosregistrales. T 5117, L 2425, F 222, S 8, H V 16880, I/A 71 ( 2.10.19).
27 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: FIDES AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 222, S 8, H V 16880, I/A 68 (20.07.18).
19 de Octubre de 2017Modificaciones estatutarias. Se modifica articulo 2潞 Estatutos en cuanto al regimen juridico. . Datos registrales. T 5117, L 2425, F221, S 8, H V 16880, I/A 67 (11.10.17).
21 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBERA NOLLA RITA;SENENT FERRER SILVESTRE;NOVO BELENGUER ALFONSO;SARRIAMORELL VICENT;SANCHIS I LABIOS AMADEUS;RIBO CANUT JOAN;CALABUIG RULL JOAN. Presidente: BARBERA NOLLA RITA.
11 de Junio de 2015Reelecciones. Auditor: FIDES AUDITORES SLP. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 221, S 8, H V 16880, I/A 65 ( 4.06.15).
21 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GRAU ALONSO ALFONSO. Vicepresid.: GRAU ALONSO ALFONSO. Nombramientos. Vicepresid.:NOVO BELENGUER ALFONSO. Consejero: MUNDINA GOMEZ CARLOS. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 220, S 8, H V 16880,I/A 64 (13.05.15).
31 de Marzo de 2014Nombramientos. Vicesecret.: REIGOSA CARDONA MARIA EMILIA. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 220, S 8, H V 16880, I/A63 (24.03.14).
20 de Mayo de 2013Revocaciones. Apoderado: BELLVER ALCANTARA MARIA JOSE. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 219, S 8, H V 16880, I/A 61(10.05.13).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODA JOSE ANTONIO. Gerente: MARTINEZ RODA JOSE ANTONIO. Datos registrales.T 5117, L 2425, F 219, S 8, H V 16880, I/A 62 (10.05.13).
07 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: BELLVER CASA脩A JORGE. Vicepresid.: BELLVER CASA脩A JORGE. Nombramientos. Consejero:MENDOZA SEGUI ALBERTO. Vicepresid.: GRAU ALONSO ALFONSO. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 218, S 8, H V 16880,I/A 59 (28.02.13).
Revocaciones. Apoderado: MASIA LEON CARLOS. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 218, S 8, H V 16880, I/A 60 (28.02.13).
26 de Diciembre de 2012Nombramientos. Auditor: FIDES AUDITORES SL. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 218, S 8, H V 16880, I/A 58 (18.12.12).
20 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: BELLVER ALCANTARA MARIA JOSE. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 217, S 8, H V 16880, I/A57 (11.07.12).
18 de Noviembre de 2011Nombramientos. Auditor: ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 217,S 8, H V 16880, I/A 56 ( 9.11.11).
21 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBERA NOLLA RITA;GRAU ALONSO ALFONSO;BELLVER CASA脩A JORGE;NOVOBELENGUER ALFONSO;GONZALEZ MOSTOLES VICENTE;RUBIO MARTINEZ RAFAEL. Presidente: BARBERA NOLLA RITA.Vicepresid.: GRAU ALONSO ALFONSO. Nombramientos. Consejero: BARBERA NOLLA RITA;BELLVER CASA脩A JORGE;GRAUALONSO ALFONSO;SENENT FERRER SILVESTRE;NOVO BELENGUER ALFONSO;SARRIA MORELL VICENT;SANCHIS I LABIOS
15 de Marzo de 2011Cambio de objeto social. A) La Sociedad tiene por objeto: 1) Estudios urban铆sticos, incluyendo en ellos la redacci贸n de planes deordenaci贸n y proyectos de urbanizaci贸n y la iniciativa para su tramitaci贸n y aprobaci贸n. 2) Actividad urbanizadora que puede alcanzartanto a la promoci贸n de la preparaci贸n del suelo y renovaci贸n. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 216, S 8, H V 16880, I/A 54 (3.03.11).
03 de Septiembre de 2010Reelecciones. Auditor: ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 216, S8, H V 16880, I/A 53 (25.08.10).
31 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 216, S8, H V 16880, I/A 52 (20.08.09).
28 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.419.550,00 Euros. Desembolsado: 3.419.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 45.600.885,00 Euros.Resultante Desembolsado: 45.600.885,00 Euros. Datos registrales. T 5117, L 2425, F 216, S 8, H V 16880, I/A 51 (17.04.09).