Actos BORME de Sociedad De Desarrollo Medioambiental De Aragon Sociedad Anonima
26 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RINCON GIMENO JAVIER;MARTIN BERNAL ENRIQUE;VICENTE LANAU ROQUE;MUNILLA LOPEZSANTIAGO PABLO;MOLINERO GARCIA MARIA PILAR;MORENO CASADO CRISTINA;SEGURA VAL MARIA JOSE;MURILLOGARCIA-ATANCE IGNACIO. Vicepresid.: RINCON GIMENO JAVIER. Consejero: ORTIZ GUTIERREZ SERGIO;LOBON SOBRINOMODESTO;CAJAL GAVIN ALFREDO. Presidente: LOBON SOBRINO MODESTO. SecreNoConsj: PEREZ MAS JUAN.Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ MONTOYA MANUEL ANGEL;LOBON SOBRINO MODESTO;RINCON GIMENO JAVIER.Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3792 , F 48, S 8, H Z 34582, I/A 21 (13.11.12).
07 de Junio de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: LOBON SOBRINO MODESTO;RINCON GIMENO JAVIER. Apo.Man.Soli: JIMENEZ MUNIESA JESUS.Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ MONTOYA MANUEL ANGEL;LOBON SOBRINO MODESTO;RINCON GIMENO JAVIER.Datos registrales. T 3792 , F 46, S 8, H Z 34582, I/A 20 (28.05.12).
23 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA LOPEZ FEDERICO. Consejero: GARCIA LOPEZ FEDERICO;IZQUIERDO AVI脩O RAFAEL.Nombramientos. Consejero: LOBON SOBRINO MODESTO;CAJAL GAVIN ALFREDO. Presidente: LOBON SOBRINO MODESTO.
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ MUNIESA JESUS;GARCIA LOPEZ FEDERICO;RINCON GIMENO JAVIER;MARTINBERNAL ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ MUNIESA JESUS. Apo.Manc.: LOBON SOBRINOMODESTO;RINCON GIMENO JAVIER. Datos registrales. T 3792 , F 45, S 8, H Z 34582, I/A 19 ( 9.05.12).
23 de Febrero de 2012Nombramientos. Consejero: ORTIZ GUTIERREZ SERGIO. Datos registrales. T 3792 , F 44, S 8, H Z 34582, I/A 17 (13.02.12).
19 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: VICENTE LANAU ROQUE;CONTRERAS TRIVI脩O ALBERTO;PRADAS ARNAL FELIX;ARTEROESCARTIN ISABEL;REVILLO PINILLA IGNACIO;VIDALLER SORO JOSE MARIA;VICENTE BARRA ALFONSO;BONE PUEYOALFREDO;MARRUEDO ESPEJA LUIS. Presidente: BONE PUEYO ALFREDO. Secretario: MARRUEDO ESPEJA LUIS. Vicepresid.:VICENTE BARRA ALFONSO. Nombramientos. Consejero: GARCIA LOPEZ FEDERICO;RINCON GIMENO JAVIER;MARTINBERNAL ENRIQUE;VICENTE LANAU ROQUE;IZQUIERDO AVI脩O RAFAEL;MUNILLA LOPEZ SANTIAGO PABLO;MOLINEROGARCIA MARIA PILAR;MORENO CASADO CRISTINA;SEGURA VAL MARIA JOSE;MURILLO GARCIA-ATANCEIGNACIO.Presidente: GARCIA LOPEZ FEDERICO. Vicepresid.: RINCON GIMENO JAVIER. SecreNoConsj: PEREZ MAS JUAN.Datos registrales. T 3792 , F 42, S 8, H Z 34582, I/A 15 ( 2.12.11).
Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ MUNIESA JESUS;JIMENEZ MUNIESA JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZMUNIESA JESUS;GARCIA LOPEZ FEDERICO;RINCON GIMENO JAVIER;MARTIN BERNAL ENRIQUE. Datos registrales. T 3792 ,F 43, S 8, H Z 34582, I/A 16 ( 2.12.11).
01 de Septiembre de 2011Nombramientos. Aud.Manc: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA;VILLALBA ENVID Y CIAAUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 3792 , F 42, S 8, H Z 34582, I/A 14 (22.08.11).
19 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: SILVA GAYOSO ROGELIO. Vicepresid.: SILVA GAYOSO ROGELIO. Nombramientos. Consejero:VICENTE BARRA ALFONSO. Vicepresid.: VICENTE BARRA ALFONSO. Reelecciones. Consejero: BONE PUEYOALFREDO;MARRUEDO ESPEJA LUIS. Presidente: BONE PUEYO ALFREDO. Secretario: MARRUEDO ESPEJA LUIS. Datosregistrales. T 3792 , F 42, S 8, H Z 34582, I/A 13 ( 6.10.10).
05 de Agosto de 2010Modificaciones estatutarias. "Art铆culo Primero: Bajo la denominaci贸n de "Sociedad de Desarrollo Medioambiental Arag贸n, S.A.,SODEMASA", se constituye una Sociedad An贸nima que se regir谩 por los presentes Estatutos y por las normas contenidas en lasdisposiciones sobrer茅gimen jur铆dico de las sociedades an贸nimas Art铆culo de los estatutos: Se elimina el inciso final delp谩rrafo primerodel art铆culo 2潞 de los Estatutos, como consecuencia el art铆culo 2潞 quedar谩 con la siguiente redacci贸n:"Art铆culo 2潞.- El objeto social de laempresa p煤blica "Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Arag贸n, S.A. SODEMASA es. Cambio de objeto social. La promoci贸n,ejecuci贸n, contrataci贸n o explotaci贸n de obras de infraestructura local, comarcal, provincial o regional y el ejercicio complementario decualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos de las infraestructuras y est茅n relacionados con 茅stas; lacontrataci贸n y prestac. Datos registrales. T 2999 , F 41, S 8, H Z 34582, I/A 12 (27.07.10).
05 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GALLEGO MONTORI JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero: VIDALLER SORO JOSE MARIA.Datos registrales. T 2999 , F 41, S 8, H Z 34582, I/A 11 (23.12.09).
03 de Marzo de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SL.Datos registrales. T 2999 , F 41, S 8, H Z 34582, I/A 9 (20.02.09).
Nombramientos. Auditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SL. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 900.000,00 Euros.Resultante Suscrito: 300.000,00 Euros. Datos registrales. T 2999 , F 41, S 8, H Z 34582, I/A 10 (20.02.09).