Actos BORME de Sociedad De Economia Mixta Aguas De Soria Sl
26 de Septiembre de 2023Reelecciones. Consejero: ANA MARIA DE LAS HERAS VALER. Datos registrales. T 224, L 173, F 193, S 8, H SO 3535, I/A 18(19.09.23).
29 de Marzo de 2023Otros conceptos: modificacion de estatutos sociales. Datos registrales. T 195, L 144, F 204, S 8, H SO 3535, I/A 17 (21.03.23).
16 de Diciembre de 2022Reelecciones. Presidente: CARLOS MARTINEZ MINGUEZ. Consejero: CARLOS MARTINEZ MINGUEZ;MIGUEL BAUTISTAMARCOS BAJO. Datos registrales. T 195, L 144, F 203, S 8, H SO 3535, I/A 15 (30.11.22).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.500.000,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art. 8. PARTICIPACIONES SOCIALES.- El capital de la sociedad estar谩 formado por 3.500 participaciones de mil euros(? 1.000) de valor nominal cada una de ellas y divididas en dos clases: A) Serie "A" compuesta por 910 participaciones numeradascorrelativamente del 1 al 910, ambos inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Su titularidad corresponde al. Otrosconceptos: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 6潞, 8潞, 16潞, 25潞 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 195, L144, F 203, S 8, H SO 3535, I/A 16 (30.11.22).
14 de Marzo de 2022Reelecciones. Consejero: ANA ALEGRE MARTINEZ;SUSANA ARIAS MONJIL. Datos registrales. T 195, L 144, F 203, S 8, H SO3535, I/A 14 ( 7.03.22).
08 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: BRACHO PACHECO ANGEL LUIS;ANTONIO MARTIN VIEIRA. Nombramientos. Consejero:SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS III SL;SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS IV SL. Datos registrales. T 195, L 144, F203, S 8, H SO 3535, I/A 13 (30.12.20).
04 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO GARCIA JESUS ANGEL. Nombramientos. Consejero: ANTONIO MARTIN VIEIRA.Reelecciones. Consejero: ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA. Secretario: ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA. Datosregistrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 12 (26.11.20).
03 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: LAPUERTA IRIGOYEN FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: OLGA FRAILEORDO脩EZ. Datos registrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 11 (23.07.20).
28 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: RIDRUEJO ALONSO ALBERTO. Datos registrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 9(21.05.19).
Nombramientos. Consejero: ANA MARIA DE LAS HERAS VALER. Datos registrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 10(21.05.19).
27 de Septiembre de 2018Reelecciones. Presidente: MARTINEZ MINGUEZ CARLOS. Consejero: MARTINEZ MINGUEZ CARLOS;RIDRUEJO ALONSOALBERTO;MARCOS BAJO MIGUEL BAUTISTA;BRACHO PACHECO ANGEL LUIS;LAPUERTA IRIGOYEN FRANCISCO JAVIER.Datos registrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 8 (21.09.18).
07 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE ANTONIO CHAMORRO GARIJO. Nombramientos. Consejero: SUSANA ARIAS MONJIL.Datos registrales. T 195, L 144, F 202, S 8, H SO 3535, I/A 7 (28.11.17).
25 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTON CACHO JAVIER;MARQUEZ ARCOS DAVID. Nombramientos. Consejero: ANA ALEGREMARTINEZ;JOSE ANTONIO CHAMORRO GARIJO. Datos registrales. T 195, L 144, F 197, S 8, H SO 3535, I/A 2 (16.08.17).
05 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SERRANO LUIS;MARCHANTE MARTINEZ JOSE ANTONIO. SecreNoConsj: ROBLESMARTIN-LABORDA AMELIA. Consejero: ABRIL MARTORELL HERNANDEZ PABLO. Nombramientos. Consejero: MARQUEZARCOS DAVID;ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA. Secretario: ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA. Consejero: BLANCOGARCIA JESUS ANGEL. Datos registrales. T 195, L 144, F 201, S 8, H SO 3535, I/A 5 (17.06.16).
04 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LAZARO BEJARANO JOSE LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: ROBLES MARTIN-LABORDA AMELIA. Datos registrales. T 195, L 144, F 201, S 8, H SO 3535, I/A 3 (19.11.15).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MEMBIELA MARTINEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SERRANOLUIS. Datos registrales. T 195, L 144, F 201, S 8, H SO 3535, I/A 4 (19.11.15).
29 de Enero de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEBRIAN RAMI MIGUEL. Apo.Manc.: ANTON CACHO JAVIER;RIDRUEJO ALONSOALBERTO;LAPUERTA IRIGOYEN FRANCISCO JAVIER;MARCOS BAJO MIGUEL BAUTISTA;MARCHANTE MARTINEZ JOSEANTONIO;BRACHO PACHECO ANGEL LUIS;CEBRIAN RAMI MIGUEL. Datos registrales. T 195, L 144, F 200, S 8, H SO 3535, I/A2 (24.12.14).
19 de Noviembre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 30.10.13. Duraci贸n: 11.11.38. Objeto social: Abastecimiento de aguas potable, riego,alcantarillado depuraci贸n del Ayuntamiento de Soria, en su t茅rmino municipal, incluyendo la realizaci贸n de obras, gesti贸n de servicios,prestaci贸n de servicios o suministros. Domicilio: PLAZA MAYOR, CASA CONSISTORIAL LOS DOCE LINAJES 7 (SORIA). Capital:5.000.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MINGUEZ CARLOS;ANTON CACHO JAVIER;RIDRUEJO ALONSOALBERTO;LAPUERTA IRIGOYEN FRANCISCO JAVIER;MARCOS BAJO MIGUEL BAUTISTA;BRACHO PACHECO ANGELLUIS;ABRIL MARTORELL HERNANDEZ PABLO;MARCHANTE MARTINEZ JOSE ANTONIO;MEMBIELA MARTINEZ JOSEANTONIO. Presidente: MARTINEZ MINGUEZ CARLOS. SecreNoConsj: LAZARO BEJARANO JOSE LUIS. VsecrNoConsj: PLAZAALMAZAN MARIA LUISA. Gerente: CEBRIAN RAMI MIGUEL. Datos registrales. T 195, L 144, F 197, S 8, H SO 3535, I/A 1(11.11.13).