Actos BORME de Sociedad De Gestion De Activos Grupo Caja Rural Del Sur Sociedad Anonima
11 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MAESTRE LEON PEDRO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ DEL CORRAL MARTINPABLO. Datos registrales. T 7287 , F 86, S 8, H SE 96002, I/A 45 ( 4.10.23).
25 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARQUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER;HAYA ZURITA JAIME;RANGEL MORON MARCOANTONIO. Datos registrales. T 7287 , F 86, S 8, H SE 96002, I/A 44 (14.04.23).
07 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ GOMEZ VICENTE;CORTINES TORRES BENITO. Nombramientos. Consejero:MAESTRE LEON PEDRO;TORRES CONDE ANTONIO. Datos registrales. T 7287 , F 85, S 8, H SE 96002, I/A 43 (30.01.23).
11 de Marzo de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ MARQUEZ JOSE ALBERTO;ZAMBRANO RUBIO LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 59, S 8,H SE 96002, I/A 39 ( 3.03.22).
01 de Marzo de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BAREA GARCIA LUIS;RUIZ MARTINEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 58, S 8, H SE 96002,I/A 38 (22.02.22).
23 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ CAMACHO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: PELAYO DIAZ YOLANDA.Datos registrales. T 5643 , F 58, S 8, H SE 96002, I/A 37 (15.12.21).
03 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: LOBATO RODRIGUEZ JUAN LUIS;ROSUA AGUILAR LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 58, S 8, H SE96002, I/A 36 (26.10.21).
23 de Julio de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 5643 , F 57, S 8, H SE 96002, I/A 35 (15.07.21).
09 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5643 , F 57, S 8, H SE 96002, I/A 34 ( 2.02.21).
03 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ PONCE PLACIDO. Datos registrales. T 5643 , F 57, S 8, H SE 96002, I/A 33 (26.10.20).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: LEFLET SOSA GENOVEVA. Datos registrales. T 5643 , F 56, S 8, H SE 96002, I/A 32 (21.10.20).
10 de Marzo de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: TALAMANTE ORTIZ JESUS ANTONIO;LAGARES MEDINA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 5643 , F56, S 8, H SE 96002, I/A 31 (25.02.20).
11 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5643 , F 56, S 8, H SE 96002, I/A 30 ( 2.07.19).
02 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: VEGA-LEAL SEGADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 56, S 8, H SE 96002, I/A 29 (24.06.19).
19 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TELLEZ VAZQUEZ GUILLERMO VICTOR;RODRIGUEZ MEJIAS EDUARDO;ALVAREZ PADILLA MARIAPATROCINIO. Datos registrales. T 5643 , F 55, S 8, H SE 96002, I/A 28 (11.06.19).
04 de Abril de 2019Modificaciones estatutarias. 22. Composici贸n consejo. Datos registrales. T 5643 , F 54, S 8, H SE 96002, I/A 25 (25.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ PALLARES JULIAN;CABALLERO INFANTE SELVA FRANCISCO;RUIZ RODRIGUEZJAVIER ALEJANDRO;MU脩OZ VACA MIGUEL;GARCIA COBOS PILAR;GARRIDO DELGADO LUCIA;GARCIA BOADA FRANCISCA.Datos registrales. T 5643 , F 55, S 8, H SE 96002, I/A 27 (26.03.19).
02 de Abril de 2019Nombramientos. Consejero: LOPEZ CRESPO DELGADO RICARDO. Otros conceptos: SE HA FIJADO EN SEIS EL N潞 DEMIEMBROS DEL CONSEJO. Datos registrales. T 5643 , F 54, S 8, H SE 96002, I/A 26 (25.03.19).
28 de Marzo de 2019Reelecciones. Consejero: LORING LASARTE JOSE MARIA;CORTINES TORRES BENITO;RODRIGUEZ GOMEZ VICENTE.
01 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5643 , F 51, S 8, H SE 96002, I/A 23 (25.07.18).
31 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: JIMENEZ MARQUEZ LORENZO. Datos registrales. T 5643 , F 51, S 8, H SE 96002, I/A 22 (23.07.18).
31 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: GOMEZ LOSADA JOSE EMILIO;VERA LOPEZ JOSE MARIA;PULIDO SANCHEZ DE LA CAMPADIEGO;GOMEZ LOSADA JOSE EMILIO;VERA LOPEZ JOSE MARIA;PULIDO SANCHEZ DE LA CAMPA DIEGO;VEGA-LEALSEGADO JOSE LUIS;RODRIGUEZ PARENTE DOMINGO EUCLIDES;PONCE TORNERO EMILIO. Nombramientos. Apo.Sol.:GARCIA PALACIOS ALVAREZ MARIA PILAR;DAZA SIERRA ANTONIO JOSE. Datos registrales. T 5643 , F 50, S 8, H SE 96002,I/A 21 (21.05.18).
14 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: GARCIA PALACIOS JOSE LUIS. Consejero: GARCIA PALACIOS JOSE LUIS. Revocaciones.Apo.Sol.: SANCHEZ BARRERO JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: TELLEZ VAZQUEZ GUILLERMO. Consejero:DOMINGUEZ CAMACHO FRANCISCO. Presidente: GARCIA PALACIOS ALVAREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 49, S8, H SE 96002, I/A 20 ( 4.05.18).
22 de Febrero de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 56.035.310,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:446.334,00 Euros. Desembolsado: 446.334,00 Euros. Resultante Suscrito: 446.334,00 Euros. Resultante Desembolsado: 446.334,00Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5643 , F 48, S 8, H SE 96002,I/A 19 (15.02.18).
09 de Octubre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAJA RURAL DEL SUR S COOP DE CREDITO. Datos registrales. T 5643 , F 48,S 8, H SE 96002, I/A 18 (29.09.17).
02 de Junio de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.917.466,00 Euros. Resultante Suscrito: 56.035.310,00 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 5643 , F 46, S 8, H SE 96002, I/A 17 (24.05.17).
16 de Marzo de 2017Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 3.078.316,00 Euros. Desembolsado: 3.078.316,00 Euros. Resultante Suscrito: 67.952.776,00 Euros.Resultante Desembolsado: 67.952.776,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital social.-. Datosregistrales. T 5643 , F 45, S 8, H SE 96002, I/A 16 ( 8.03.17).
08 de Junio de 2016Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MOYANO JESUS;ZAMBRANO RUBIO LUIS;RODRIGUEZ PARENTE DOMINGOEUCLIDES;RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL;LOBATO RODRIGUEZ JUAN LUIS;PONCE TORNERO EMILIO;PEREZBARRERA MANUEL;VEGA-LEAL SEGADO JOSE LUIS;GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO;ROSUA AGUILAR LUIS;TIRADOSANCHEZ ANTONIO;MORENO SANCHEZ FRANCISCO JOSE;RODRIGUEZ MONTERO ANTONIO;ALVAREZ REY TERESA. Datosregistrales. T 5643 , F 45, S 8, H SE 96002, I/A 14 (30.05.16).
24 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ CAMACHO FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA PALACIOSALVAREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 44, S 8, H SE 96002, I/A 13 (13.11.15).
28 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: FARI脩AS ROMERO MARTIN. Datos registrales. T 5643 , F 43, S 8, H SE 96002, I/A 12 (20.10.15).
10 de Julio de 2015Nombramientos. Apoderado: FARI脩AS ROMERO MARTIN. Datos registrales. T 5643 , F 42, S 8, H SE 96002, I/A 11 (30.06.15).
28 de Mayo de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: MACIAS MIRANDA MANUEL;VEGA-LEAL SEGADO JOSE LUIS. Datos registrales. T 5643 , F 41, S 8, HSE 96002, I/A 10 (21.05.15).
27 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ MEJIAS EDUARDO;LAGARES MEDINA JOSE CARLOS;SANCHEZ BARRERO JOSEANTONIO Datos registrales. T 5643 , F 40, S 8, H SE 96002, I/A 9 (18.05.15).
17 de Marzo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ PADILLA MARIA DEL PATROCINIO;GONZALEZ MARQUEZ JOSE ALBERTO. Datosregistrales. T 5643 , F 39, S 8, H SE 96002, I/A 8 (10.03.15).
30 de Enero de 2015Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 5643 , F 39, S 8, H SE 96002, I/A 7 (19.01.15).
23 de Junio de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: PALACIOS GOMEZ JUAN ANGEL;RODRIGUEZ MONTIEL JOSE CASTO;SANCHEZ PARRALEJOFRANCISCO. Datos registrales. T 5643 , F 38, S 8, H SE 96002, I/A 6 (12.06.14).
12 de Mayo de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ LOSADA JOSE EMILIO;CANO CASTILLA BEATRIZ;VERA LOPEZ JOSE MARIA;PULIDOSANCHEZ DE LA CAMPA DIEGO;VAZQUEZ FERNANDEZ FRANCISCO;VEGA-LEAL SEGADO JOSE LUIS;JIMENEZ MARQUEZLORENZO;GONZALEZ PONCE PLACIDO;TALAMANTE ORTIZ JESUS ANTONIO;TELLEZ VAZQUEZ GUILLERMOVICTOR;LANZAROTE FERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 5643 , F 37, S 8, H SE 96002, I/A 5 (25.04.14).
21 de Febrero de 2014Revocaciones. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ JOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ TARRUELLA MARTIN RAFAEL.Datos registrales. T 5643 , F 36, S 8, H SE 96002, I/A 4 (12.02.14).
26 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: MACIAS MIRANDA MANUEL;PALACIOS GOMEZ JUAN ANGEL;GOMEZ LOSADA JOSE EMILIO;CANOCASTILLA BEATRIZ;VERA LOPEZ JOSE MARIA;RODRIGUEZ MONTIEL JOSE CASTO;PULIDO SANCHEZ DE LA CAMPADIEGO;VAZQUEZ FERNANDEZ FRANCISCO;VEGA-LEAL SEGADO JOSE LUIS;SANCHEZ PARRALEJO FRANCISCO. Datosregistrales. T 5643 , F 35, S 8, H SE 96002, I/A 3 (18.04.13).
19 de Febrero de 2013Otros conceptos: El apoderado podr谩 realizar las facultades con los l铆mites que resultan de la escritura otorgada en Sevilla, el d铆a 26de diciembre de 2.012, ante su notario don Arturo Otero L贸pez-Cubero, n煤mero 6.766 de protocolo.- Datos registrales. T 5643 , F 34,S 8, H SE 96002, I/A 2 ( 5.02.13).
13 de Febrero de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.12.12. Objeto social: La gesti贸n, administraci贸n y enajenaci贸n de cualesquiera activosinmobiliarios relacionados con el suelo para promoci贸n inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias... Domicilio:C/ MURILLO 2 - 41.001 (SEVILLA). Capital suscrito: 64.874.460,00 Euros. Desembolsado: 64.874.460,00 Euros. Nombramientos.Consejero: GARCIA PALACIOS JOSE LUIS;DOMINGUEZ CAMACHO FRANCISCO;LORING LASARTE JOSE MARIA;CORTINESTORRES BENITO;RODRIGUEZ GOMEZ VICENTE. Datos registrales. T 5643 , F 30, S 8, H SE 96002, I/A 1 ( 4.02.13).
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ LOPEZ JOAQUIN. Presidente: GARCIA PALACIOS JOSE LUIS. Secretario: LORINGLASARTE JOSE MARIA. Datos registrales. T 5643 , F 34, S 8, H SE 96002, I/A 2 ( 5.02.13).