Actos BORME de Sociedad De Suministros Y Servicios Interlaken 2003 Sl
01 de Octubre de 2013Revocaciones. APODERADO: GRAU PUJADAS GREGORIO. Datos registrales. T 39967 , F 28, S 8, H B 278810, I/A 17(23.09.13).
05 de Abril de 2011Nombramientos. APODERADO: MANCILLA SANCHEZ PABLO;FRANCO RODRIGUEZ ALEJANDRO;HERNANDEZ ESTERUELASSERGI;MUIÑO SANCHEZ ALVARO;DE AMOS FERNANDEZ ANA. Datos registrales. T 39967 , F 27, S 8, H B 278810, I/A 16(24.03.11).
09 de Septiembre de 2010Revocaciones. APODERADO: BALCELLS CAZE MANUEL;LEDESMA VARGAS DIEGO. Datos registrales. T 39967 , F 27, S 8, HB 278810, I/A 15 (30.08.10).
23 de Agosto de 2010Nombramientos. APODERADO: MANCILLA SANCHEZ PABLO. Datos registrales. T 39967 , F 26, S 8, H B 278810, I/A 14(11.08.10).
30 de Julio de 2010Nombramientos. APODERADO: GRAU PUJADAS GREGORIO. Datos registrales. T 39967 , F 25, S 8, H B 278810, I/A 13(20.07.10).
31 de Diciembre de 2009Cambio de domicilio social. PS DE GRACIA Num.46 P.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 39967 , F 24, S 8, H B 278810, I/A12 (18.12.09).
26 de Octubre de 2009Revocaciones. REPR.143 RRM: MARFA PONS GENIS. Nombramientos. REPR.143 RRM: FERNANDEZ GOMEZ CARLOS.Datos registrales. T 39967 , F 24, S 8, H B 278810, I/A 11 (14.10.09).
19 de Mayo de 2009Revocaciones. ADM.UNICO: ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIA. REPR.143 RRM: MARFA PONSGENIS. Nombramientos. REPR.143 RRM: MARFA PONS GENIS. ADM.UNICO: AGUAS DE INTERLAKEN SL. Datos registrales.T 39967 , F 24, S 8, H B 278810, I/A 10 ( 6.05.09).
09 de Marzo de 2009Cambio de domicilio social. CL MUNTANER Num.340 P.PR (BARCELONA). Datos registrales. T 39967 , F 23, S 8, H B 278810,I/A 9 (25.02.09).