Buscador CIF Logo

Actos BORME Sociedad Gala De Inversiones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sociedad Gala De Inversiones Sl

Actos BORME Sociedad Gala De Inversiones Sl - B28625986

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sociedad Gala De Inversiones Sl con CIF B28625986

馃敊 Perfil de Sociedad Gala De Inversiones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sociedad Gala De Inversiones Sl

03 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: SAN MILLAN BRASA MARIA EUGENIA. Nombramientos. Apo.Sol.: BALLEGA AU脩ONINMACULADA;GRANADOS PLEGUEZUELOS PALOMA. Datos registrales. T 26950 , F 33, S 8, H M 77191, I/A 58 (27.07.23).

Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 45204 , F 130, S 8, H M 77191, I/A 59 (27.07.23).

18 de Enero de 2023
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26950 , F 33, S 8, H M 77191, I/A 57 (11.01.23).

29 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 26950 , F 32, S 8, H M 77191, I/A 56 (21.12.22).

19 de Mayo de 2022
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 26950 , F 32, S 8, H M 77191, I/A 55 (11.05.22).

27 de Noviembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 26950 , F 31, S 8, H M 77191, I/A 54 (20.11.20).

31 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Representan: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CALVOGERARDO. Datos registrales. T 26950 , F 31, S 8, H M 77191, I/A 53 (23.12.19).

30 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26950 , F 30, S 8, H M 77191, I/A 52 (23.10.19).

03 de Julio de 2019
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 26950 , F 30, S 8, H M 77191, I/A 51 (26.06.19).

07 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Nombramientos. VsecrNoConsj: SILVA RUIZ DEL OLMOBLANCA. Datos registrales. T 26950 , F 30, S 8, H M 77191, I/A 50 (31.01.19).

18 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 26950 , F 29, S 8, H M 77191, I/A 49 (11.07.18).

10 de Abril de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: SAN MILLAN BRASA MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 26950 , F 29, S 8, H M 77191, I/A 48 (2.04.18).

21 de Agosto de 2017
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 26950 , F 28, S 8, H M 77191, I/A 47 (10.08.17).

26 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DE HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan:VARELA TORRES NURIA MARTA. Datos registrales. T 26950 , F 28, S 8, H M 77191, I/A 46 (18.07.17).

10 de Febrero de 2017
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 26950 , F 28, S 8, H M 77191, I/A 45 ( 2.02.17).

07 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Nombramientos. Consejero: CANETONIN SL;ANGERANSL;VALDEQUINILLA SL. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Representan: LOPEZ DE HIERRO PEREZ MINGUEZFRANCISCO JAVIER;RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO;PETROSSI VALDES EDUARDO ALFREDO. Modificacionesestatutarias. nueva redaccion de los estatutos Sociales . Datos registrales. T 26950 , F 19, S 8, H M 77191, I/A 44 (29.09.16).

17 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.

14 de Julio de 2015
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 26950 , F 19, S 8, H M 77191, I/A 42 ( 3.07.15).

25 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 26950 , F 19, S 8, H M 77191, I/A 41 (17.06.14).

12 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Auditor: ATA AUDITORES SL. Datos registrales. T 26950 , F 19, S 8, H M 77191, I/A 40 ( 5.09.13).

18 de Julio de 2013
Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 26950 , F 17, S 8, H M 77191, I/A 37 (10.07.13).

Nombramientos. Apoderado: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA;CALVO CAMINEROMERCEDES. Datos registrales. T 26950 , F 18, S 8, H M 77191, I/A 38 (10.07.13).

Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 26950 , F 18, S 8, H M 77191, I/A 39 (10.07.13).

09 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datosregistrales. T 26950 , F 17, S 8, H M 77191, I/A 36 ( 2.07.13).

16 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 26950 , F 16, S 8, H M 77191, I/A 35 ( 5.04.13).

22 de Octubre de 2012
Cambio de objeto social. LA ADQUISICION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION, CESION Y ENAJENACION, PORCUALQUIER TITULO, DE VALORES MOBILIARIOS Y DE CUALQUIER TIPO DE TITULOSQUE CONCEDAN UNA PARTICIPACIONEN SOCIEDADES... Datos registrales. T 26950 , F 16, S 8, H M 77191, I/A 34 ( 9.10.12).

05 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 26950 , F 16, S 8, H M 77191, I/A 33 (25.06.12).

21 de Junio de 2012
Cambio de domicilio social. C/ GUZMAN EL BUENO 133 9& (MADRID). Datos registrales. T 26950 , F 15, S 8, H M 77191, I/A 32( 8.06.12).

06 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 26950 , F 15, S 8, H M 77191, I/A 31 (24.06.11).

26 de Enero de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 142.022,31 Euros. Resultante Suscrito: 4.833.079,73 Euros. Datos registrales. T 26950 ,F 14, S 8, H M 77191, I/A 30 (17.01.11).

10 de Septiembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Secretario: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE.Revocaciones. Apoderado: DIAZ ALBISU JOSE LUIS;DIAZ ALBISU JOSE LUIS;GERVAS DIEZ GERMAN;TRINCHANT BLASCOCARLOS JOSE. Nombramientos. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Presidente: GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. SecreNoConsj: TRIGO SIERRA LUIS FERNANDO. Datosregistrales. T 26950 , F 13, S 8, H M 77191, I/A 29 (26.08.10).

24 de Septiembre de 2009
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Representan: GERVAS DIEZ GERMAN. SecreNoConsj: DIAZALBISU JOSE LUIS. VsecrNoConsj: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Consejero: IPL INTERNATIONAL LTD. Presidente: IPLINTERNATIONAL LTD. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Nombramientos. SecreNoConsj: TRINCHANT BLASCOCARLOS JOSE. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Ampliaci贸n de capital. Capital: 888.302,04 Euros. ResultanteSuscrito: 4.975.102,04 Euros. Modificaciones estatutarias. ART. 26潞 .- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION. Datosregistrales. T 4699 , F 221, S 8, H M 77191, I/A 26 (31.08.09).

Nombramientos. Apoderado: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE;CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 26950 , F 11, S 8, H M 77191, I/A 27 (14.09.09).

Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 26950 , F 12, S 8, H M 77191, I/A 28 (14.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n