Actos BORME de Sociedad Hispanica De Desarrollo Sociedad Anonima
25 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANGUESA GARGALLO JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIBEIRO ANTONIO AMERICODE CONCEICAO;PEDREIRA FREIRE CARLOS ANTONIO;SANGUESA GARGALLO JESUS;PEDREIRA FREIRE CARLOSANTONIO;LACARCEL AISA CLARA ELISA;SANGUESA GARGALLO JESUS. Datos registrales. T 2955 , F 156, S 8, H SS 4660, I/A133 (18.02.21).
19 de Febrero de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: SENDIN GABRIEL RAFAEL. Apoderado: SENDIN GABRIEL RAFAEL. Datos registrales. T 2955 , F156, S 8, H SS 4660, I/A 132 ( 8.02.21).
31 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2955 , F 156, S 8, H SS 4660, I/A131 (17.12.20).
22 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: AUCHAN RETAIL ESPA脩A SL. Nombramientos. Adm. Unico: ALCAMPO SA. Datos registrales.T 2955 , F 147, S 8, H SS 4660, I/A 128 (15.10.20).
Nombramientos. Apoderado: PASTOR TORTOSA CAROLINA. Datos registrales. T 2955 , F 147, S 8, H SS 4660, I/A 129(15.10.20).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLONDE (EP. BOUVIER) ISABELLE CLAUDINE FRANCOISE;LOPEZ RODRIGUEZJESUS;SANGUESA GARGALLO JESUS. Datos registrales. T 2955 , F 149, S 8, H SS 4660, I/A 130 (15.10.20).
02 de Octubre de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ZELAIRA SA. AUCHAN RETAIL DURANGO SL. Datos registrales. T 2955 , F 145,S 8, H SS 4660, I/A 127 (23.09.20).
17 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRASTORZA GUILISAGASTI JAVIER. Datos registrales. T 2741 , F 94, S 8, H SS 4660, I/A 126(26.08.20).
01 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: SERRANO MARTINEZ VALENTIN. Apo.Manc.: LOPEZ RODRIGUEZ JESUS. Apo.Man.Soli:LEPOUTRE FRANCIS. Apoderado: KORTABARRIA ARTETA PILAR;ESTEBAN MARTINEZ JOSE VICENTE. Apo.Man.Soli: ROJASESPINO RAMON;SERRANO MARTINEZ VALENTIN. Apoderado: FAJARDO FERNANDEZ DE BOBADILLA JOSE LUIS. Apo.Sol.:SAMITIER RAYMOND ANTOINE. Apo.Manc.: SAMITIER RAYMOND ANTOINE. Apo.Sol.: ROJAS ESPINO RAMON. Apo.Manc.:ROJAS ESPINO RAMON. Apoderado: HERRERO VILLORIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 2741 , F 93, S 8, H SS 4660, I/A124 (23.03.20).
27 de Enero de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2741 , F 93, S 8, H SS 4660, I/A123 ( 9.01.20).
09 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA RIVAS JUAN-ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA RIVAS JUAN-ANTONIO;MANTEROLA ARIZMENDI BORJA. Datos registrales. T 2741 , F 92, S 8, H SS 4660, I/A 122 ( 2.10.19).
26 de Septiembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ RODRIGUEZ JESUS;SANGUESA GARGALLO JESUS;LACARCEL AISA CLARA ELISA.Datos registrales. T 2741 , F 92, S 8, H SS 4660, I/A 121 (16.09.19).
21 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2741 , F 92, S 8, H SS 4660, I/A120 ( 4.12.18).
19 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apoderado: SENDIN GABRIEL RAFAEL. Datos registrales. T 2741 , F 91, S 8, H SS 4660, I/A 119 ( 6.11.18).
11 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ GARCIA ANTONIO JESUS;COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE;ALONSOVILLOSLADA PEDRO. Secretario: SENDIN GABRIEL RAFAEL. Presidente: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE.Nombramientos. Adm. Unico: AUCHAN RETAIL ESPA脩A SL. Otros conceptos: Como consecuencia del cambio de Organo deAdministracion MODIFICAR LOS ARTICULOS 2, 3, 6, 8, 10, 12, y 15 a 27, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales, as铆 como laderogaci贸n expresa del art铆culo 28. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Ampliacion del objeto social. 3. La elaboraci贸n y manipulado de productos alimentarios y otros productos destinados al consumohumano y derivados, platos preparados, precodnados, salsas alimenticias, y en general, de productos para la alimentaci贸n humana;para su consumo en el propio establecimiento explotado por la Sociedad o p. Datos registrales. T 2741 , F 89, S 8, H SS 4660, I/A118 (28.08.18).
29 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2741 , F 89, S 8, H SS 4660, I/A117 (20.12.17).
11 de Octubre de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Con.Delegado: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Reelecciones.Consejero: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Presidente: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE.Datos registrales. T 2741 , F 89, S 8, H SS 4660, I/A 116 ( 4.10.17).
17 de Enero de 2017Reelecciones. Consejero: LOPEZ GARCIA ANTONIO JESUS;ALONSO VILLOSLADA PEDRO. Datos registrales. T 2741 , F 85, S8, H SS 4660, I/A 114 (10.01.17).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2741 , F 88, S 8, H SS 4660, I/A115 (10.01.17).
10 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: SERRA LAMAZARES CRISTINA. Datos registrales. T 2741 , F 85, S 8, H SS 4660, I/A 113(27.04.16).
18 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ PATRICIA VANESA. Datos registrales. T 2354 , F 58, S 8, H SS 4660, I/A112 ( 8.04.16).
22 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: GAROZ ESTEBAN EMILIO. Datos registrales. T 2354 , F 58, S 8, H SS 4660, I/A 111 (11.12.15).
26 de Junio de 2014Reelecciones. Consejero: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Presidente: COIGNARD PATRICK LOUISANTOINE JEAN MARIE. Con.Delegado: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Datos registrales. T 2354 , F 58, S8, H SS 4660, I/A 110 (16.06.14).
13 de Diciembre de 2013Reelecciones. Consejero: ALONSO VILLOSLADA PEDRO. Datos registrales. T 2354 , F 58, S 8, H SS 4660, I/A 109 ( 4.12.13).
15 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ GARCIA ANTONIO JESUS.Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 108 ( 7.10.13).
11 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL. Nombramientos. Consejero: LOPEZ GARCIA ANTONIOJESUS. Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 107 (30.08.13).
22 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 106 (10.07.13).
29 de Enero de 2013Nombramientos. Apoderado: GAROZ ESTEBAN EMILIO. Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 104 (22.01.13).
Nombramientos. Apoderado: DE OPAZO OLANO ANA ISABEL. Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 105(22.01.13).
06 de Julio de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2354 , F 56, S 8, H SS 4660, I/A 103 (28.06.12).
02 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: VERDU DIAZ FRANCISCO. Datos registrales. T 2354 , F 55, S 8, H SS 4660, I/A 102 (20.03.12).
21 de Septiembre de 2011Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2354 , F 55, S 8, H SS 4660, I/A 101 (12.09.11).
17 de Mayo de 2011Reelecciones. Consejero: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Presidente: COIGNARD PATRICK LOUISANTOINE JEAN MARIE. Consejero: RODRIGUEZ HERNANDEZ DANIEL. Datos registrales. T 2354 , F 55, S 8, H SS 4660, I/A 99 (
Nombramientos. Apoderado: HERRERO VILLORIA MARIA ISABEL. Datos registrales. T 2354 , F 55, S 8, H SS 4660, I/A 100 (6.05.11).
19 de Noviembre de 2010Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ALCAMPO SA. Datos registrales. T 2354 , F 55, S 8, H SS 4660, I/A 98 (10.11.10).
07 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: DE VEGA MARTINEZ JUVENAL CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARES SUEIRO JOSELUIS. Datos registrales. T 2354 , F 53, S 8, H SS 4660, I/A 97 (28.09.10).
08 de Julio de 2010Reelecciones. Consejero: ALONSO VILLOSLADA PEDRO. Datos registrales. T 1739 , F 225, S 8, H SS 4660, I/A 95 (30.06.10).
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2354 , F 53, S 8, H SS 4660, I/A 96 (30.06.10).
04 de Enero de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1739 , F 225, S 8, H SS 4660, I/A 94 (22.12.09).
18 de Diciembre de 2009Reelecciones. Consejero: COIGNARD PATRICK LOUIS ANTOINE JEAN MARIE. Presidente: COIGNARD PATRICK LOUISANTOINE JEAN MARIE. Datos registrales. T 1739 , F 225, S 8, H SS 4660, I/A 93 ( 9.12.09).