Actos BORME de Sociedad Inversora En Energia Y Medioambiente Sa
23 de Septiembre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Revocaciones. Apo.Sol.: MARCOS ROMERO JOSE. Apo.Manc.:MARCOS ROMERO JOSE. Apoderado: ENRILE VILLAGRAN JUAN;PEREZ RODRIGUEZ JESUS. Apo.Manc.: MARCOS ROMEROJOSE. Apo.Man.Soli: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;LUNA GARCIA JOSELUIS;FERNANDEZ FUENTES DAVID;GARCIA HERNANDEZ IGNACIO;BALBOA LINARES SALVADOR;PASTOR FERNANDEZVICTOR MANUEL;RUIZ GARCIA CRISTINA. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 5121 , F 88, S 8, H SE 25060,I/A 40 (16.09.19).
20 de Agosto de 2019Declaración de unipersonalidad. Socio único: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Datos registrales. T 5121 , F 88, S 8, H SE 25060,I/A 39 (12.08.19).
05 de Julio de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ MORENO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 5121 , F 88, S 8, H SE 25060, I/A 38(28.06.19).
03 de Mayo de 2019Modificaciones estatutarias. 24. Organo de administración.-. Datos registrales. T 5121 , F 87, S 8, H SE 25060, I/A 37 (24.04.19).
23 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ABENGOA SA. Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA ABENEWCO 1 SA. Otros conceptos:La entidad administradora unica de la sociedad de referencia, designa a DON JOAQUIN FERNANDEZ DE PIEROLA MARIN comorepresentante persona fisica para el ejercicio de tal cargo. Datos registrales. T 5121 , F 87, S 8, H SE 25060, I/A 36 (12.04.19).
05 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MARCOS ROMERO JOSE. Apo.Manc.: MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ LORA JUANCARLOS;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Sol.: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;CORREA PORTILLO SANTIAGO.Apo.Man.Soli: CORREA PORTILLO SANTIAGO;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: CORREA PORTILLOSANTIAGO;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUELANGEL;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;LUNA GARCIA JOSE LUIS;FERNANDEZ MORENO MIGUEL ANGEL;FERNANDEZFUENTES DAVID;GARCIA HERNANDEZ IGNACIO;BALBOA LINARES SALVADOR;PASTOR FERNANDEZ VICTOR MANUEL;RUIZGARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 5121 , F 85, S 8, H SE 25060, I/A 35 (26.02.18).
27 de Septiembre de 2017Modificaciones estatutarias. 9 BIS. Pignoración de las acciones.- . Datos registrales. T 5121 , F 85, S 8, H SE 25060, I/A 34(19.09.17).
27 de Abril de 2017Otros conceptos: A los efectos de lo establecido en el articulo 122.3 del R.R.M., se hace constar que con fecha 27 de febrero de2017, se pusieron en circulación dos título multiples, números 1 y 2, representativo de la totalidad de las acciones en que se divide elcapital social de esta sociedad. Datos registrales. T 3537 , F 67, S 8, H SE 25060, I/A20-bi (18.04.17).
18 de Abril de 2016Otros conceptos: "ABENGOA, S.A.", cesa a DON JOSE DOMINGUEZ ABASCAL como representante persona física en el ejerciciode las funciones de administrador único de la Sociedad y designa como nuevo representante persona física a Don Joaquín Fernándezde Piérola Marín.- Datos registrales. T 3537 , F 74, S 8, H SE 25060, I/A 33 ( 7.04.16).
08 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA MERCEDES;BENJUMEA LLORENTE MARIA TERESA;MONTESFUENTES IGNACIO;FERNANDEZ DE BOBADILLA AYA MIRIAM;MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS.Presidente: MARCOS ROMERO JOSE. Vicepresid.: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. SecreNoConsj: ALAMINOS ECHARRI DANIEL.Nombramientos. Adm. Unico: ABENGOA SA. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTICULOS 3º, 10º, 13º, 17º,18º,22º,23º,24º Y 25º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administrador único. Datos registrales. T 3537 , F 73, S 8, H SE 25060, I/A 32 ( 1.04.16).
26 de Enero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VILLAVERDE Y SILVA ALVARO. Datos registrales. T 3537 , F 73, S 8, H SE 25060,I/A 31 (15.01.16).
22 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3537 , F 72, S 8, H SE 25060, I/A 30 (14.01.16).
22 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ VELASCO MAZARIOMIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ VILLAVERDE Y SILVA ALVARO. SecreNoConsj: ALAMINOSECHARRI DANIEL. Datos registrales. T 3537 , F 72, S 8, H SE 25060, I/A 29 (15.01.15).
07 de Noviembre de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS;CORREA PORTILLO SANTIAGO. Apo.Man.Soli: CORREA PORTILLOSANTIAGO;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Apo.Manc.: CORREA PORTILLO SANTIAGO;JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 3537 , F 70, S 8, H SE 25060, I/A 28 (28.10.14).
14 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: LARA SAENZ ANDRES. Datos registrales. T 3537 , F 70, S 8, H SE 25060, I/A 27 ( 4.04.14).
26 de Julio de 2012Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3537 , F 69, S 8, H SE 25060, I/A25 (13.07.12).
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3537 , F 70, S 8, H SE 25060, I/A 26 (13.07.12).
17 de Mayo de 2012Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3537 , F 69, S 8, H SE 25060,I/A 24 ( 2.05.12).
27 de Diciembre de 2011Nombramientos. Consejero: BENJUMEA LLORENTE MARIA MERCEDES;BENJUMEA LLORENTE MARIA TERESA;LARA SAENZANDRES;MONTES FUENTES IGNACIO;FERNANDEZ DE BOBADILLA AYA MIRIAM. Reelecciones. Consejero: JIMENEZ LORAJUAN CARLOS. Presidente: MARCOS ROMERO JOSE. Vicepresid.: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Consejero: MARCOSROMERO JOSE;JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL.Modificaciones estatutarias. 22. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 3537 , F 68, S 8, H SE 25060, I/A 23(13.12.11).
16 de Agosto de 2011Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -CAMPUS PALMAS ALTAS, CP 41014 (SEVILLA). Datos registrales. T 3537 , F 68, S 8, H SE 25060, I/A 22 ( 3.08.11).
04 de Diciembre de 2009Reelecciones. Consejero: JIMENEZ LORA JUAN CARLOS. Presidente: MARCOS ROMERO JOSE. Vicepresid.: JIMENEZ LORAJUAN CARLOS. Consejero: MARCOS ROMERO JOSE;JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Secretario: JIMENEZVELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3537 , F 67, S 8, H SE 25060, I/A 21 (23.11.09).
01 de Diciembre de 2009Nombramientos. Secretario: JIMENEZ VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 2268 , F 14, S 8, H SE 25060,I/A 8 (26.11.97).
27 de Enero de 2009Reducción de capital. Importe reducción: 29.054.910,50 Euros. Resultante Suscrito: 10.640.889,30 Euros. Modificaciones