Actos BORME de Sociedad Municipal De Viviendas De Malaga Sl
18 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Consejero: DE LA TORRE PRADOSFRANCISCO;POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER;FLORIDO GOMEZ JACOBO;CARDADOR JIMENEZ JOSE;RODRIGUEZVELA ROSA DEL MAR;VIRUEL DEL CASTILLO RUBEN;LOSADA MORENO NOELIA. Presidente: DE LA TORRE PRADOSFRANCISCO. Consejero: RAMOS SANCHEZ REMEDIOS;MARTIN ORTIZ MARIA DEL CARMEN. Nombramientos. Consejero: DELA TORRE PRADOS FRANCISCO;POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER;CASERO NAVARRO CARMEN;CANTOS RECALDEFRANCISCO MANUEL;PEREZ DE SILES CALVO ELISA;MARTIN ORTIZ MARIA DEL CARMEN;RUIZ ARAUJO MARIANO;GOMEZMARIN YOLANDA;SGUIGLIA NICOLAS EDUARDO. Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Datos registrales. T 5735, L4642, F 5, S 8, H MA109238, I/A 32 (29.09.23).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GUTIERREZ COLOMINA VENANCIO. VsecrNoConsj: SERRANO ROMERA ALEJANDRO.Vsecr2.NC: GARCIA DE HERRERA FERNANDEZ JORGE. Nombramientos. VsecrNoConsj: PEREZ-GASCON ORTIZ DEQUINTANA VIRGINIA. SecreNoConsj: LEON GROSS JORGE. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 5, S 8, H MA109238, I/A 33(29.09.23).
Nombramientos. Vicepresid.: POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 5, S 8, HMA109238, I/A 34 (29.09.23).
16 de Marzo de 2023Otros conceptos: MODIFICACION TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 2, S 8, HMA109238, I/A 31 ( 9.03.23).
20 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: MURILLO LOPEZ ALICIA. Nombramientos. Consejero: MARTIN ORTIZ MARIA DEL CARMEN.Datos registrales. T 5735, L 4642, F 2, S 8, H MA109238, I/A 30 (12.01.23).
05 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: ZORRILLA DIAZ EDUARDO ESTEBAN. Nombramientos. Consejero: RAMOS SANCHEZREMEDIOS. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 2, S 8, H MA109238, I/A 29 (25.06.21).
04 de Agosto de 2020Nombramientos. Auditor: UNICONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 2, S 8, HMA109238, I/A 28 (23.07.20).
30 de Octubre de 2019Otros conceptos: Se amplian facultades al Director General don José María López Cerezo. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 2,S 8, H MA109238, I/A 27 (22.10.19).
06 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CARBALLO GUTIERREZ ALEJANDRO DAMIAN;BRENES COBOS SERGIO;JIMENEZ SANTAELLAISABEL;DOÑA MORALES LORENA;TORRES CASADO DE AMEZUA MARIA DEL MAR. Nombramientos. Consejero: FLORIDOGOMEZ JACOBO;MURILLO LOPEZ ALICIA;RODRIGUEZ VELA ROSA DEL MAR;VIRUEL DEL CASTILLO RUBEN;LOSADAMORENO NOELIA. Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: DE LA TORRE PRADOSFRANCISCO;POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER;CARDADOR JIMENEZ JOSE;ZORRILLA DIAZ EDUARDO ESTEBAN.Datos registrales. T 5735, L 4642, F 1, S 8, H MA109238, I/A 26 (25.07.19).
25 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: JIMENEZ JIMENEZ RAUL. Nombramientos. Consejero: TORRES CASADO DE AMEZUA MARIADEL MAR. Datos registrales. T 5735, L 4642, F 1, S 8, H MA109238, I/A 25 (14.03.19).
30 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDRADE RUIZ JULIO. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ JIMENEZ RAUL. Datos
10 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: UNICONTROL AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 171, S 8, HMA109238, I/A 23 (28.12.17).
30 de Noviembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ MORALES DANIEL. Nombramientos. Consejero: DOÑA MORALES LORENA. Datosregistrales. T 4881, L 3789, F 171, S 8, H MA109238, I/A 22 (20.11.17).
31 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRALBO CALZADO YSABEL DE LOS ANGELES. Nombramientos. Consejero: JIMENEZSANTAELLA ISABEL. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 171, S 8, H MA109238, I/A 21 (23.05.17).
25 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Vsecr2.NC: LEON MORENO CRISTINA MARIA. Nombramientos. Vsecr2.NC: GARCIA DE HERRERAFERNANDEZ JORGE. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 171, S 8, H MA109238, I/A 20 (12.04.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CEREZO JOSE MARIA. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 170, S 8, H MA109238, I/A 18 (6.03.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOÑA MORALES LORENA. Nombramientos. Consejero: BRENES COBOS SERGIO. Datosregistrales. T 4881, L 3789, F 170, S 8, H MA109238, I/A 19 ( 6.03.17).
17 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: CARBALLO GUTIERREZ ALEJANDRO DAMIAN. Nombramientos. Consejero: CASSALOMBARDIA JUAN. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 170, S 8, H MA109238, I/A 15 ( 9.11.16).
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARCIA DE HERRERA FERNANDEZ JORGE. Nombramientos. VsecrNoConsj: SERRANOROMERA ALEJANDRO. Vsecr2.NC: LEON MORENO CRISTINA MARIA. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 170, S 8, HMA109238, I/A 16 ( 9.11.16).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASSA LOMBARDIA JUAN. Nombramientos. Consejero: CARBALLO GUTIERREZ ALEJANDRODAMIAN. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 170, S 8, H MA109238, I/A 17 ( 9.11.16).
10 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: PORRAS TERUEL MARIA TERESA. Nombramientos. Consejero: CARDADOR JIMENEZ JOSE.Datos registrales. T 4881, L 3789, F 168, S 8, H MA109238, I/A 14 ( 1.08.16).
21 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: MEDINA SANCHEZ MARIA BEGOÑA;BRENES COBOS SERGIO JOSE;CARDADOR JIMENEZJOSE;LOPEZ CEREZO JOSE MARIA;CASERO NAVARRO CARMEN. Nombramientos. Consejero: ANDRADE RUIZJULIO;PORRAS TERUEL MARIA TERESA;PEREZ MORALES DANIEL;TORRALBO CALZADO YSABEL DE LOSANGELES;CARBALLO GUTIERREZ ALEJANDRO DAMIAN. Reelecciones. Consejero: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO.Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Consejero: ZORRILLA DIAZ EDUARDO ESTEBAN;DOÑA MORALESLORENA;POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 168, S 8, H MA109238, I/A 13(13.04.16).
22 de Octubre de 2015Nombramientos. Auditor: R. & L. AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 168, S 8, H MA109238, I/A 12 (14.10.15).
27 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: PORRAS TERUEL TERESA. Nombramientos. Consejero: MALDONADO CARRILLO DIEGO.Datos registrales. T 4881, L 3789, F 167, S 8, H MA109238, I/A 10 (16.12.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MALDONADO RAUL;DEL CORRAL PARRA GEMMA;JIMENEZ JIMENEZRAUL;MALDONADO CARRILLO DIEGO. Nombramientos. Consejero: POMARES FUERTES FRANCISCO JAVIER;CARDADORJIMENEZ JOSE;LOPEZ CEREZO JOSE MARIA;CASERO NAVARRO CARMEN. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 167, S 8, HMA109238, I/A 11 (16.12.13).
10 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MALDONADO CARRILLO DIEGO. Nombramientos. Consejero: PORRAS TERUEL TERESA.Modificaciones estatutarias. 25. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 167, S 8, H MA109238,I/A 9 ( 1.07.13).
20 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ GARCIA VICTOR MANUEL;HERNANDEZ PEZZI CARLOS;GUERRERO MORENOCRISTINA. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ JIMENEZ RAUL;BRENES COBOS SERGIO JOSE;DOÑA MORALES LORENA.Datos registrales. T 4881, L 3789, F 166, S 8, H MA109238, I/A 7 ( 8.05.13).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CEREZO JOSE MARIA. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 166, S 8, H MA109238, I/A 8 (8.05.13).
15 de Octubre de 2012Ampliación de capital. Capital: 432.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 26.915.000,00 Euros. Datos registrales. T 4881, L 3789, F165, S 8, H MA109238, I/A 6 ( 1.10.12).
26 de Abril de 2012Nombramientos. Auditor: R. & L. AUDITORES SL. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 165, S 8, H MA109238, I/A 5 (17.04.12).
02 de Marzo de 2012Ampliación de capital. Capital: 26.423.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 26.483.000,00 Euros. Datos registrales. T 4881, L 3789,F 164, S 8, H MA109238, I/A 4 (20.02.12).
13 de Octubre de 2011Nombramientos. VsecrNoConsj: GARCIA DE HERRERA FERNANDEZ JORGE. Otros conceptos: De conformidad con el artículo20º de los estatutos se establece una periodicidad para la celebración de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración deSEIS MESES, a contar desde la primera sesión del Consejo de Administración.-Se amplían las facultades del DIRECTOR-GERENTE,don José María López Cerezo. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 163, S 8, H MA109238, I/A 2 (29.09.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUIRADO MANUEL JAVIER;LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA;GRANADOS RUIZRAFAEL;ZAMORA BERMUDEZ MARIA DEL MAR;NAVAJAS ORTEGA LUIS FRANCISCO;MORENO BRENES PEDRO.Nombramientos. Consejero: GONZALEZ GARCIA VICTOR MANUEL;DEL CORRAL PARRA GEMMA;HERNANDEZ PEZZICARLOS;GUERRERO MORENO CRISTINA;MEDINA SANCHEZ MARIA BEGOÑA;ZORRILLA DIAZ EDUARDO ESTEBAN.Reelecciones. Consejero: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Consejero:MALDONADO CARRILLO DIEGO;LOPEZ MALDONADO RAUL. Modificaciones estatutarias. Se modifica el párrafo primero delartículo 17º de los estatutos.. Se modifica el artículo 25 in fine de los estatutos.. Datos registrales. T 4881, L 3789, F 164, S 8, HMA109238, I/A 3 (30.09.11).
30 de Mayo de 2011Constitución. Comienzo de operaciones: 14.02.11. Objeto social: La Sociedad servirá con objetividad los intereses generales propiosdel municipio de Málaga, según la legislación local y la urbanística, dedicándosea la promoción de viviendas protegidas en régimen demercado, para atenderla demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o ma. Domicilio: C/ SPENGLER S/N(MALAGA). Capital: 60.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socio único: AYUNTAMIENTO DE MALAGA.Nombramientos. SecreNoConsj: GUTIERREZ COLOMINA VENANCIO. Consejero: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO.Presidente: DE LA TORRE PRADOS FRANCISCO. Consejero: MALDONADO CARRILLO DIEGO;DIAZ GUIRADO MANUELJAVIER;LOPEZ MALDONADO RAUL;LOPEZ MUÑOZ MARIA TERESA;GRANADOS RUIZ RAFAEL;ZAMORA BERMUDEZ MARIADEL MAR;NAVAJAS ORTEGA LUIS FRANCISCO;MORENO BRENES PEDRO. D. Gerente: LOPEZ CEREZO JOSE MARIA. Datosregistrales. T 4881, L 3789, F 161, S 8, H MA109238, I/A 1 (18.05.11).