Actos BORME de Sociedad Para El Desarrollo De Calamocha Sa
17 de Enero de 2023Reelecciones. Coauditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA;CGM AUDITORES SL. Datos registrales. T4375 , F 132, S 8, H Z 44569, I/A 33 (10.01.23).
20 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCOBAR DE LA IGLESIA JAIME VICTOR. Nombramientos. Consejero: CORPORACIONEMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON SOCIEDAD. Datos registrales. T 4375 , F 132, S 8, H Z 44569, I/A 32 (13.12.22).
25 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: SAS LLUSA PEDRO. Datos registrales. T 4375 , F 131, S 8, H Z 44569, I/A 31 (19.04.22).
22 de Abril de 2022Fe de erratas: El cargo para el que se designa a ARIZNAVARRETA TEJEDOR, MARTA, es el de VICESECRETARIA NOCONSEJERA (y no Secretaria no Consejera). Datos registrales. T 4375 , F 129, S 8, H Z 44569, I/A 29 ( 3.03.22).
10 de Marzo de 2022Nombramientos. SecreNoConsj: ARIZNAVARRETA TEJEDOR MARTA. L. Asesor: BIENDICHO GRACIA LUIS. Datos registrales. T4375 , F 129, S 8, H Z 44569, I/A 29 ( 3.03.22).
Revocaciones. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Apo.Sol.: DE LA FUENTE GOMEZ FRANCISCO. Nombramientos.Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Datos registrales. T 4375 , F 129, S 8, H Z 44569, I/A 30 ( 3.03.22).
14 de Enero de 2022Nombramientos. Coauditor: VILLALBA ENVID Y CIA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA;CGM AUDITORES SL. Datos registrales.T 4375 , F 129, S 8, H Z 44569, I/A 28 ( 7.01.22).
13 de Abril de 2021Modificaciones estatutarias. Artículo 32 bis.- Reuniones por medios telemáticos. Las sesiones de los órganos de gobierno (JuntasGenerales) y de los órganos de administración de la sociedad (Consejo de Administración) podrán constituirse y celebrarse por mediostelemáticos (videoconferencia o conferencia múltiple) que aseguren Artículo 33.- El consejo quedará válidamente constituido cuandoconcurran al mismo presentes o representados por otro Consejero la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirámediante escrito dirigido al Presidente y será especial para cada reunión del Consejo. Los acuerdos se Articulo 33 bis. Acuerdos porescrito y sin sesión. Serán válidos también los acuerdos adoptados por escrito y sin sesión siempre que ningún consejero se oponga aeste procedimiento de adopción de acuerdos. Tanto el escrito conteniendo los acuerdos como el sentido del voto de los Consejerospodrán Articulo 32.- El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que estime conveniente, pero, cuando menos, una vezcada tres meses, salvo que por el Presidente se estime la conveniencia de modificar dicha periodicidad por. .cualquier circunstanciaque así lo justifique. La convocatoria se. Datos registrales. T 4375 , F 128, S 8, H Z 44569, I/A 27 ( 7.04.21).
29 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PINEDO GUILLEN JOSE LUIS;PEREZ PUEYO SERGIO;EMBID LOPEZ JULIO. Cancelaciones deoficio de nombramientos. Consejero: TEJEDOR SANZ RAMON. Presidente: TEJEDOR SANZ RAMON. Nombramientos.Consejero: TEJEDOR SANZ RAMON. Presidente: TEJEDOR SANZ RAMON. Consejero: ALMALE BANDRES RICARDO;ESCOBARDE LA IGLESIA JAIME VICTOR. Datos registrales. T 4375 , F 128, S 8, H Z 44569, I/A 26 (20.10.20).
29 de Julio de 2020Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: PEREZ PUEYO SERGIO. Reelecciones. Consejero: RANDO LOPEZMANUEL. Vicepresid.: RANDO LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 4375 , F 128, S 8, H Z 44569, I/A 25 (22.07.20).
09 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. AVDA RANILLLAS - EDIFICIO 1 D, 3ª PLANTA, OFICINA (ZARAGOZA). Datos registrales. T 4375 , F127, S 8, H Z 44569, I/A 24 ( 2.03.20).
28 de Febrero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMERO FUERTES MARIA LUISA;BERNAL BLAY MIGUEL ANGEL;NAVARRO MUÑOZ RUBEN.Nombramientos. Consejero: LOPEZ CORBATON INOCENCIO. Datos registrales. T 4375 , F 127, S 8, H Z 44569, I/A 23(21.02.20).
26 de Agosto de 2019Revocaciones. Apoderado: CRESPO MARTIN JOAQUIN. Nombramientos. Apoderado: LOSTAO GARCIA BELEN. Datosregistrales. T 4375 , F 126, S 8, H Z 44569, I/A 22 (19.08.19).
24 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: TEJEDOR SANZ RAMON. Apo.Manc.: RANDO LOPEZ MANUEL. Nombramientos. Apo.Sol.: DE LAFUENTE GOMEZ FRANCISCO;TEJEDOR SANZ RAMON;RANDO LOPEZ MANUEL. Cambio de domicilio social. AVDARANILLAS, EDIFICIO 1-D 3ª - OFICINA I (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3546 , F 34, S 8, H Z 44569, I/A 20 (18.12.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENEZ ALLUEVA ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: EMBID LOPEZ JULIO. Datosregistrales. T 4375 , F 126, S 8, H Z 44569, I/A 21 (18.12.18).
05 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROMERO IZQUIERDO MARIA DOLORES. Nombramientos. SecreNoConsj: CABEZAMURILLO CLAUDIA. Datos registrales. T 3546 , F 34, S 8, H Z 44569, I/A 19 (26.10.18).
05 de Enero de 2017Ampliación de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.760.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.760.000,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 34, S 8, H Z 44569, I/A 18 (28.12.16).
08 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Presidente: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Consejero: BARRADO VICENTEPEDRO. Vicepresid.: BARRADO VICENTE PEDRO. Consejero: GAMON YUSTE JAVIER;RANDO LOPEZ MANUEL;PERIBAÑEZPEIRO JOAQUIN;QUEROL MARTIN JOSE RAMON;SANMARTIN MORA MARIA ASUNCION;CERVERA RUIZ PEDRO.Nombramientos. Consejero: TEJEDOR SANZ RAMON. Presidente: TEJEDOR SANZ RAMON. Consejero: RANDO LOPEZMANUEL. Vicepresid.: RANDO LOPEZ MANUEL. Consejero: PINEDO GUILLEN JOSE LUIS;GIMENEZ ALLUEVA ENRIQUE;PEREZPUEYO SERGIO;BERNAL BLAY MIGUEL ANGEL;ROMERO FUERTES MARIA LUISA;NAVARRO MUÑOZ RUBEN. Datosregistrales. T 3546 , F 32, S 8, H Z 44569, I/A 16 (31.05.16).
Revocaciones. Apo.Sol.: ALIAGA LOPEZ ARTURO;BARRADO VICENTE PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDORSANZ RAMON. Apo.Manc.: RANDO LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 3546 , F 32, S 8, H Z 44569, I/A 17 (31.05.16).
21 de Noviembre de 2014Ampliación de capital. Suscrito: 500.000,00 Euros. Desembolsado: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.460.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.460.000,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 32, S 8, H Z 44569, I/A 15 (12.11.14).
22 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: CARO AIZCORBE ELENA. Nombramientos. Consejero: CERVERA RUIZ PEDRO. Datosregistrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 13 (15.10.14).
Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 32º.- El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que estime conveniente,pero, cuando menos, una vez cada seis meses, salvo que por el Presidente se estime la conveniencia de modificar dicha periodicidadpor cualquier circunstancia que asilo justifique. La convocatoria se. Datos registrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 14(15.10.14).
01 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LARDIES RUIZ MERCEDES. Nombramientos. Consejero: SANMARTIN MORA MARIAASUNCION. Datos registrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 11 (23.09.13).
Nombramientos. Apoderado: CRESPO MARTIN JOAQUIN. Datos registrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 12 (23.09.13).
28 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LARIO HERNANDEZ SILVIA. Nombramientos. Consejero: QUEROL MARTIN JOSERAMON;CARO AIZCORBE ELENA. Datos registrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 10 (17.05.13).
12 de Febrero de 2013Ampliación de capital. Suscrito: 790.000,00 Euros. Desembolsado: 790.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.960.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.960.000,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 31, S 8, H Z 44569, I/A 9 ( 1.02.13).
29 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: INSTITUTO ARAGONES DE FOMENTO;GASION AGUILAR ANTONIO. Presidente: INSTITUTOARAGONES DE FOMENTO. Consejero: PERIBAÑEZ PEIRO JOAQUIN. SecreNoConsj: ROMERO IZQUIERDO MARIA DOLORES.Nombramientos. SecreNoConsj: ROMERO IZQUIERDO MARIA DOLORES. Consejero: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Presidente:ALIAGA LOPEZ ARTURO. Consejero: BARRADO VICENTE PEDRO. Vicepresid.: BARRADO VICENTE PEDRO. Consejero: LARDIESRUIZ MERCEDES;GAMON YUSTE JAVIER;LARIO HERNANDEZ SILVIA;RANDO LOPEZ MANUEL;PERIBAÑEZ PEIRO JOAQUIN.Modificaciones estatutarias. "La administración y representación de la Sociedad corresponderá al Consejo de Administración, queserá designado por la Junta General. El Consejo de Administración estará compuesto por un número de consejeros no inferior a 3 nisuperior a 8, renovándose cada 4 años, pudiendo ser reelegidos una o. Datos registrales. T 3546 , F 29, S 8, H Z 44569, I/A 7(18.05.12).
Revocaciones. Apoderado: ALIAGA LOPEZ ARTURO. Nombramientos. Apo.Sol.: ALIAGA LOPEZ ARTURO;BARRADO VICENTEPEDRO. Datos registrales. T 3546 , F 30, S 8, H Z 44569, I/A 8 (18.05.12).
29 de Abril de 2011Ampliación de capital. Suscrito: 470.000,00 Euros. Desembolsado: 470.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.170.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.170.000,00 Euros. Datos registrales. T 3546 , F 29, S 8, H Z 44569, I/A 6 (15.04.11).
29 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: PAMPLONA ABAD MIGUEL. Datos registrales. T 3546 , F 29, S 8, H Z 44569, I/A 5 (18.06.09).