Actos BORME de Sociedad Para La Explotacion Y Recuperacion De Activos Sl
30 de Diciembre de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 30684 , F 134, S 8, H M 552141, I/A 4 (17.12.13).
18 de Noviembre de 2013Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30684 , F 134, S 8, H M 552141, I/A 3 ( 8.11.13).
27 de Mayo de 2013Cambio de domicilio social. PASEO DE RECOLETOS 17 (MADRID). Datos registrales. T 30684 , F 134, S 8, H M 552141, I/A 2(17.05.13).
10 de Mayo de 2013Otros conceptos: Extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, al haberse expedido con fecha dehoy, certificaci贸n literal para traslado de domicilio a la provinciade Madrid. Datos registrales. T 1461 , F 94, S 8, H GR 12780, I/A D (2.05.13).
27 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORPORACION CAJA DE GRANADA SL. Nombramientos. Adm. Mancom.: CORPORACIONEMPRESARIAL CAJA MURCIA SL. Datos registrales. T 1461 , F 94, S 8, H GR 12780, I/A 32 (20.03.13).
28 de Diciembre de 2012Otros conceptos: Se cesa como representante f铆sico en el ejercicio del cargode Adm. mancomunado por parte de "BANCO MARENOSTRUM SA" enla Sociedad "SOCIEDAD PARA LA EXPLOTACION Y RECUPERACION DEACTIVOS SL" a Don Salvador CurielChaves, y se designa comonuevo representante f铆sico a DON ANGEL GABRIEL GIL SEVILLANO. Datos registrales. T 1461 , F 94, S8, H GR 12780, I/A 31 (20.12.12).
22 de Agosto de 2012Revocaciones. Apoderado: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Sol.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apoderado:MONTESINOS SUAREZ RAFAEL;MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Manc.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Sol.:MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Manc.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Sol.: MONTESINOS SUAREZRAFAEL;MONTESINOS SUAREZ RAFAEL;MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Manc.: LOPEZ ROBLES MANUEL;LOPEZROBLES MANUEL;LOPEZ ROBLES MANUEL. Apo.Sol.: LOPEZ ROBLES MANUEL;LOPEZ ROBLES MANUEL;LOPEZ ROBLESMANUEL;LOPEZ ROBLES MANUEL;LOPEZ ROBLES MANUEL. Apo.Man.Soli: LOPEZ ROBLES MANUEL. Datos registrales. T1420 , F 183, S 8, H GR 12780, I/A 29 (10.08.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: LOYOLA ESCOBEDO JORGE;MARTINEZ MERCADO MANUEL;AGUAYO FERREIRARAFAEL;LORENZO MONTIEL MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: LOYOLA ESCOBEDO JORGE;AGUAYO FERREIRARAFAEL;LORENZO MONTIEL MIGUEL ANGEL. Apoderado: LOYOLA ESCOBEDO JORGE. Apo.Manc.: MARTINEZ MERCADOMANUEL. Datos registrales. T 1420 , F 183, S 8, H GR 12780, I/A 30 (10.08.12).
10 de Agosto de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: BANCO MARE NOSTRUM SA. Ceses/Dimisiones. Consejero:ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL;GARCIA BEATO FRANCISCO. Presidente: GARCIA BEATOFRANCISCO. Consejero: DIAZ RUIZ CESAR. SecreNoConsj: MARTINEZ MERCADO MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.:BANCO MARE NOSTRUM SA;CORPORACION CAJA DE GRANADA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados.ARTICULO 18.- Se modificaen cuanto al plazo deduraci贸n del cargo de administrador, que lo era indefinido, pasando a ser por un plazo de cinco a帽os.. Datos registrales. T 1420 , F182, S 8, H GR 12780, I/A 28 ( 2.08.12).
16 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 1420 , F 181, S 8, H GR 12780, I/A 26 ( 4.01.12).
Nombramientos. Apoderado: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 1420 , F 182, S 8, H GR 12780, I/A 27 (4.01.12).
16 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Gerente: GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ NAVARROFERNANDO;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Apo.Man.Soli: GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Apo.Manc.: GONZALEZNAVARRO FERNANDO. Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL. Apo.Manc.:MONTESINOS SUAREZ RAFAEL;ESPIGARES CERDAN JOAQUIN. Apoderado: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Sol.:MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Apo.Manc.: LOPEZ ROBLES MANUEL. Apo.Sol.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL;ESPIGARESCERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL. Apo.Manc.: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL;ESPIGARES CERDANJOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL. Gerente: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 1420 , F 180, S 8, H GR12780, I/A 25 ( 4.08.11).
27 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BAUTISTA GUTIERREZ AQUILINO. Nombramientos. Consejero: DIAZ RUIZ CESAR. Datosregistrales. T 1364 , F 87, S 8, H GR 12780, I/A 23 (16.06.11).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GUTIERREZ CONDE ROSA. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ MERCADOMANUEL. Datos registrales. T 1364 , F 87, S 8, H GR 12780, I/A 24 (16.06.11).
07 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: BENITEZ LOPEZ FERNANDO;FERNANDEZ ROCHES M& FERNANDA;ABAD GOMEZANTONIO;MORENO CABEZAS PILAR;CONEJO MARTINEZ BELEN;MARTIN DE LOS RIOS MERCEDES;ALES SIOLISIGNACIO;GORDILLO ALCALA MAURICIO;NAVARRETE AMADO INMACULADA;RUIZ LORENZO DAVID ANGEL;GALVEZ TORRESPUCHOL FRANCISCO J.;PEREZ CUEVAS MIGUEL;JIMENEZ MARTINEZ CARLOS;VALCARCEL ALCAZAR GLORIA;SOBRINOCORTES CARLOS JAVIER;MARTINEZ BASTIDA M& JOSEFA;GUBERN VIVES JOSEP;MONTES AGUSTIN ROSINA;CASTILLOSANCHEZ MIGUEL ANGEL. Apo.D.Gral.: GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Apo.Sol.: MONTESINOS SUAREZRAFAEL;LORENZO MONTIEL MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1364 , F 86, S 8, H GR 12780, I/A 21 (24.02.11).
15 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 50.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 65.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1364 , F 86, S8, H GR 12780, I/A 20 ( 4.02.11).
07 de Septiembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 15.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 1364 , F 86, S8, H GR 12780, I/A 19 (27.08.10).
07 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL;MONTESINOS SUAREZRAFAEL;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO;ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL. Datos registrales. T1364 , F 85, S 8, H GR 12780, I/A 18 (28.06.10).
29 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: CARMONA SALGADO ALFREDO. Consejero: CARMONA SALGADO ALFREDO;GARCIA LOPEZJOAQUIN DIEGO. Presidente: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN. Nombramientos. Consejero: GARCIA BEATO FRANCISCO.SecreNoConsj: GUTIERREZ CONDE ROSA. Presidente: GARCIA BEATO FRANCISCO. Datos registrales. T 1364 , F 85, S 8, H GR12780, I/A 17 (18.06.10).
21 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ ROBLES MANUEL;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO;ESPIGARES CERDAN JOAQUIN.Datos registrales. T 1364 , F 85, S 8, H GR 12780, I/A 16 (10.12.09).
18 de Diciembre de 2009Cambio de domicilio social. C/ GRAN VIA DE COLON 14 SEGUNDO (GRANADA). Datos registrales. T 1364 , F 85, S 8, H GR12780, I/A 15 ( 9.12.09).
18 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO.Datos registrales. T 1364 , F 84, S 8, H GR 12780, I/A 13 ( 6.11.09).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.596.751,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.000.000,00 Euros. Otros conceptos: Se modifica elvalor de las participaciones sociales, desdeel actual de 30,0506 Euros, a UN EURO, refundiendo el anterior capital con el ampliado,modificando, asimismo, adem谩s del valor, el n煤mero de las participaciones sociales. Datos registrales. T 1364 , F 84, S 8, H GR12780, I/A 14 ( 9.11.09).
14 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ ROBLES MANUEL ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: ESPIGARES CERDANJOAQUIN;BAUTISTA GUTIERREZ AQUILINO;LOPEZ ROBLES MANUEL;GARCIA LOPEZ JOAQUIN DIEGO;CARMONA SALGADOALFREDO. Presidente: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN. Secretario: CARMONA SALGADO ALFREDO. Apo.Sol.: ESPIGARESCERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Gerente: GONZALEZ NAVARRO FERNANDO.Apo.Sol.: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN;LOPEZ ROBLES MANUEL;GONZALEZ NAVARRO FERNANDO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1364 , F82, S 8, H GR 12780, I/A 12 ( 2.10.09).
27 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: MONTESINOS SUAREZ RAFAEL. Datos registrales. T 800 , F 5, S 8, H GR 12780, I/A 10 (18.08.09).
Nombramientos. Apoderado: FERRER BUENO AMPARO. Datos registrales. T 1364 , F 81, S 8, H GR 12780, I/A 11 (18.08.09).
25 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ESPIGARES CERDAN JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ ROBLES MANUELENRIQUE. Ampliaci贸n de capital. Capital: 400.243,94 Euros. Resultante Suscrito: 403.249,00 Euros. Cambio de domicilio social.AVDA FERNANDO DE LOS RIOS 6 (GRANADA). Datos registrales. T 800 , F 5, S 8, H GR 12780, I/A 9 (13.03.09).