Actos BORME de Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima
08 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: PEREIRA SAN MARTIN MONICA. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 71, S 8, H V 18297, I/A 134 (1.06.23).
05 de Junio de 2023Reelecciones. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 71, S 8, H V 18297, I/A 133(29.05.23).
14 de Febrero de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ SANCHEZ MARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Apo.Sol.: FERNANDEZ SANCHEZMARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Fe de erratas: Se omitieron los nombramientos de los apoderados de los grupos B y C Publicadoen el Bolet铆n 237 de fecha 14/12/21 y referencia 05385892021. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A 127 (3.12.21).
Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO. Apo.Man.Soli: GARCIA LOPEZ BEATRIZ.Apo.Manc.: GARCIA BERRAL LUIS. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SANCHEZ MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA GARCIAMARIA CANDELA;ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO;FERNANDEZ SANCHEZ MARIA;GARCIA LOPEZBEATRIZ;GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 70, S 8, H V 18297, I/A 132 ( 7.02.23).
08 de Julio de 2022Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n de los art铆culos 16 y 18 de los Estatutos de la Sociedad relativos,respectivamente, al lugar de celebraci贸n del Consejo de Administraci贸n y a la retribuci贸n.. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 70, S8, H V 18297, I/A 131 ( 1.07.22).
30 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: BARTOLOME YLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;CALLEJO RAMIROPALOMA;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;MU脩OZ CARRERO ALMUDENA;HERNANI BURZAKO JAVIER;BERMEJO DEL VALLECARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Nombramientos.Apo.Manc.: BARTOLOME YLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER;MU脩OZCARRERO ALMUDENA;CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;ARENAL BARRIOS MARIA DOLORES;PEREIRA SAN MARTIN MONICA;FERNANDEZ AZPICUETAIGNACIO;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 69, S 8, H V 18297, I/A 130 (23.06.22).
27 de Junio de 2022Reelecciones. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Consejero: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F69, S 8, H V 18297, I/A 129 (20.06.22).
11 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Secretario: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Vicesecret.: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Nombramientos.SecreNoConsj: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 69, S 8, H V 18297, I/A 128 ( 4.04.22).
14 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SANCHEZMARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A127 ( 3.12.21).
14 de Octubre de 2021Cambio de domicilio social. C/ PINTOR SOROLLA 23 (VALENCIA). Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A126 ( 6.10.21).
19 de Agosto de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANI BURZAKO JAVIER;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;BARTOLOME YLLERAMARTA. Apo.Manc.: CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;WARREN CANO BRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Manc.: BARTOLOMEYLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;CALLEJO RAMIRO PALOMA;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;MU脩OZCARRERO ALMUDENA;HERNANI BURZAKO JAVIER;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 67, S 8, H V 18297, I/A 125 (12.08.21).
14 de Junio de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A 124 ( 7.06.21).
31 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE. Nombramientos. Consejero: NICOLAS TAHOCESFRANCISCO. Reelecciones. Consejero: PARDO TORNERO ANGEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A123 (24.05.21).
14 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ DE LA ROSA GABRIEL. Nombramientos. Consejero: ALONSO-MAJAGRANZASCENAMOR BEATRIZ. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A 121 ( 6.10.20).
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V18297, I/A 122 ( 6.10.20).
24 de Julio de 2019Reelecciones. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE. Secretario: CASTRO MARTINEZALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 65, S 8, H V 18297, I/A 120 (17.07.19).
09 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 65, S 8, H V18297, I/A 119 ( 2.07.19).
10 de Agosto de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARREN CANOBRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;CALLEJO RAMIRO PALOMA;LUZON GOMEZESTIBALIZ;FERNANDEZ SIMAL ANTOLIN MARIA JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARTOLOME YLLERAMARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARREN CANO BRIAN;RIOS JIMENEZMARIA CRISTINA;CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 118 ( 3.08.18).
15 de Junio de 2018Reelecciones. Consejero: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Consejero: DOMINGUEZ DE LAROSA GABRIEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 117 ( 8.06.18).
08 de Marzo de 2018Nombramientos. Vicesecret.: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 116 (1.03.18).
08 de Mayo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero: PARDO TORNERO ANGEL.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 63, S 8, H V 18297, I/A 115 (27.04.17).
23 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: RIOS NAVARRO ALEJANDRO;BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES. Datos registrales. T 4904, L 2213,F 63, S 8, H V 18297, I/A 114 (16.12.16).
21 de Octubre de 2016Nombramientos. Apo.Man.Soli: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARRENCANO BRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;CALLEJO RAMIRO PALOMA;LUZON GOMEZESTIBALIZ;FERNANDEZ SIMAL ANTOLIN MARIA JESUS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 61, S 8, H V 18297, I/A 111(14.10.16).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 62, S 8, H V 18297, I/A 112 (14.10.16).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO;CASTROMARTINEZ ALVARO. Apo.Man.Soli: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO.
27 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 60, S 8, H V18297, I/A 110 (20.05.16).
15 de Febrero de 2016Otros conceptos: Modificaci贸n y refundici贸n de Estatutos. Las modificaciones introducidas en los Estatutos sociales de la Sociedadtienen por finalidad adaptar su contenido a la normativa en vigor, en particular a la Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que semodifica la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 59, S 8, H V 18297, I/A 109 ( 8.02.16).
16 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO. Secretario: BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES.Vicesecret.: RIOS NAVARRO ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Secretario: CASTROMARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 58, S 8, H V 18297, I/A 108 ( 9.11.15).
02 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ REQUENA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: YZAGUIRRE SCHARFHAUSENJORGE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 58, S 8, H V 18297, I/A 107 (25.09.15).
30 de Abril de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORRO MARTI MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 57, S 8, H V 18297, I/A 106 (23.04.15).
27 de Agosto de 2014Modificaciones estatutarias. Modificacion de la retribucion del Organo de Administraci贸n. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 27,S 8, H V 18297, I/A 105 (20.08.14).
01 de Julio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRE GONZALEZ ANGEL;ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Presidente: TORRE GONZALEZANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero:OLMOS IBA脩EZ VICENTE;DOMINGUEZ DE LA ROSA GABRIEL. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Reelecciones.Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 103 (24.06.14).
Revocaciones. Apoderado: TORRE GONZALEZ ANGEL;TORRE GONZALEZ ANGEL;TORRE GONZALEZ ANGEL.Nombramientos. Apoderado: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 104(24.06.14).
25 de Junio de 2013Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V18297, I/A 102 (18.06.13).
16 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VELA BARGUES JORGE. Nombramientos. Consejero: DIAZ REQUENA FERNANDO. Datosregistrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 101 ( 4.10.12).
07 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 54, S 8, H V 18297, I/A 100 (27.07.12).
01 de Agosto de 2012Otros conceptos: Modificacion y refundicion de estatutos.ARTICULO 16 . COMPOSICION. 1. La direcci贸n, administraci贸n yrepresentaci贸n de la Sociedad corresponde al Consejo de Administraci贸n que estar谩 integrado por un m铆nimo de cinco y un m谩ximo desiete miembros, personas f铆sicas y cuyo n煤mero exacto se determinar谩por la junta General la cual habr谩 de. P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.bolsavalencia.es. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 52, S 8, H V 18297,I/A 99 (23.07.12).
19 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO ALBEROLA JESUS. Nombramientos. Consejero: AMIGO SALMERON JULIOFRANCISCO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 52, S 8, H V 18297, I/A 98 ( 7.12.11).
25 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO;MORO MARTI MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: BLASCO ARGILES JOSEMIGUEL;MARTIN GARCIA JOSE LUIS;CASTRO MARTINEZ ALVARO;COSCOLLA LOPEZ BALBINA. Apoderado: COSCOLLALOPEZ BALBINA. Apo.Manc.: COSCOLLA LOPEZ BALBINA;AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO;CARSI CALVET VICENTE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORRO MARTI MIGUEL ANGEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO;AMIGO SALMERON JULIOFRANCISCO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 97 (14.10.11).
04 de Julio de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 96 (23.06.11).
28 de Febrero de 2011Reelecciones. Consejero: NAVARRO ALBEROLA JESUS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 95(17.02.11).
11 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MALDONADO RUBIO JOAQUIN. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 94(29.10.10).
27 de Mayo de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 93 (18.05.10).
20 de Abril de 2010Fe de erratas: Error al practicar la inscripci贸n en cuanto al cese del Consejero Don Benito Castillo Navarro, quedando estesubsistente. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 9 (25.11.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTILLO NAVARRO BENITO;TRIGO BEAUMONT AGUSTIN;PEREZ BOADA ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: VELA BARGUES JORGE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 92 ( 9.04.10).
08 de Febrero de 2010Revocaciones. Apoderado: GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Apo.Manc.: GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Apoderado:GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: MORO MARTI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4904, L2213, F 47, S 8, H V 18297, I/A 91 (28.01.10).
04 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y RUMEU LUIS;CASTILLO NAVARROBENITO;TORRE GONZALEZ ANGEL. Presidente: TORRE GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL.Consejero: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Consejero: PEREZ BOADA ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL;TORRE GONZALEZ ANGEL;ESCAMEZ SANCHEZMANUEL;PEREZ BOADA ENRIQUE. Presidente: TORRE GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL.Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 9 (25.11.09).
19 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SUBIES MONTALAR FELIX. Otros conceptos: EL CONSEJO QUEDA FIJADO EN 9 MIEMBROS.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 89 ( 9.06.09).
01 de Junio de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 88 (21.05.09).