Buscador CIF Logo

Actos BORME Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima

Actos BORME Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima - A46641866

Tenemos registrados 49 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima con CIF A46641866

馃敊 Perfil de Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Sociedad Rectora De La Bolsa De Valores De Valencia Sociedad Anonima

08 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: PEREIRA SAN MARTIN MONICA. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 71, S 8, H V 18297, I/A 134 (1.06.23).

05 de Junio de 2023
Reelecciones. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 71, S 8, H V 18297, I/A 133(29.05.23).

14 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ SANCHEZ MARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Apo.Sol.: FERNANDEZ SANCHEZMARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Fe de erratas: Se omitieron los nombramientos de los apoderados de los grupos B y C Publicadoen el Bolet铆n 237 de fecha 14/12/21 y referencia 05385892021. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A 127 (3.12.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO. Apo.Man.Soli: GARCIA LOPEZ BEATRIZ.Apo.Manc.: GARCIA BERRAL LUIS. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SANCHEZ MARIA. Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA GARCIAMARIA CANDELA;ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO;FERNANDEZ SANCHEZ MARIA;GARCIA LOPEZBEATRIZ;GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 70, S 8, H V 18297, I/A 132 ( 7.02.23).

08 de Julio de 2022
Modificaciones estatutarias. Se modifica la redacci贸n de los art铆culos 16 y 18 de los Estatutos de la Sociedad relativos,respectivamente, al lugar de celebraci贸n del Consejo de Administraci贸n y a la retribuci贸n.. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 70, S8, H V 18297, I/A 131 ( 1.07.22).

30 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: BARTOLOME YLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;CALLEJO RAMIROPALOMA;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;MU脩OZ CARRERO ALMUDENA;HERNANI BURZAKO JAVIER;BERMEJO DEL VALLECARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEY IZQUIERDO MIGUEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Nombramientos.Apo.Manc.: BARTOLOME YLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER;MU脩OZCARRERO ALMUDENA;CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;ARENAL BARRIOS MARIA DOLORES;PEREIRA SAN MARTIN MONICA;FERNANDEZ AZPICUETAIGNACIO;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 69, S 8, H V 18297, I/A 130 (23.06.22).

27 de Junio de 2022
Reelecciones. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Consejero: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F69, S 8, H V 18297, I/A 129 (20.06.22).

11 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Vicesecret.: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Nombramientos.SecreNoConsj: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 69, S 8, H V 18297, I/A 128 ( 4.04.22).

14 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: ROMERO GIL MARIA;ANDRES PARAMIO SANTIAGO. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SANCHEZMARIA;GARCIA LOPEZ BEATRIZ. Apo.Manc.: GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A127 ( 3.12.21).

14 de Octubre de 2021
Cambio de domicilio social. C/ PINTOR SOROLLA 23 (VALENCIA). Datos registrales. T 4904, L 2213, F 68, S 8, H V 18297, I/A126 ( 6.10.21).

19 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERNANI BURZAKO JAVIER;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;BARTOLOME YLLERAMARTA. Apo.Manc.: CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;WARREN CANO BRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA. Nombramientos. Apo.Manc.: BARTOLOMEYLLERA MARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;CALLEJO RAMIRO PALOMA;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;MU脩OZCARRERO ALMUDENA;HERNANI BURZAKO JAVIER;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 67, S 8, H V 18297, I/A 125 (12.08.21).

14 de Junio de 2021
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A 124 ( 7.06.21).

31 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE. Nombramientos. Consejero: NICOLAS TAHOCESFRANCISCO. Reelecciones. Consejero: PARDO TORNERO ANGEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A123 (24.05.21).

14 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DOMINGUEZ DE LA ROSA GABRIEL. Nombramientos. Consejero: ALONSO-MAJAGRANZASCENAMOR BEATRIZ. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V 18297, I/A 121 ( 6.10.20).

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 66, S 8, H V18297, I/A 122 ( 6.10.20).

24 de Julio de 2019
Reelecciones. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE. Secretario: CASTRO MARTINEZALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 65, S 8, H V 18297, I/A 120 (17.07.19).

09 de Julio de 2019
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 65, S 8, H V18297, I/A 119 ( 2.07.19).

10 de Agosto de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARREN CANOBRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;CALLEJO RAMIRO PALOMA;LUZON GOMEZESTIBALIZ;FERNANDEZ SIMAL ANTOLIN MARIA JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARTOLOME YLLERAMARTA;YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARREN CANO BRIAN;RIOS JIMENEZMARIA CRISTINA;CALLEJO RAMIRO PALOMA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;LUZON GOMEZ ESTIBALIZ;ALASTRUEYIZQUIERDO MIGUEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 118 ( 3.08.18).

15 de Junio de 2018
Reelecciones. Consejero: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Consejero: DOMINGUEZ DE LAROSA GABRIEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 117 ( 8.06.18).

08 de Marzo de 2018
Nombramientos. Vicesecret.: DIEZ HERRERO ALEJANDRO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 64, S 8, H V 18297, I/A 116 (1.03.18).

08 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL. Nombramientos. Consejero: PARDO TORNERO ANGEL.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 63, S 8, H V 18297, I/A 115 (27.04.17).

23 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apo.Sol.: RIOS NAVARRO ALEJANDRO;BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES. Datos registrales. T 4904, L 2213,F 63, S 8, H V 18297, I/A 114 (16.12.16).

21 de Octubre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: YZAGUIRRE SCHARFHAUSEN JORGE;HERNANI BURZAKO JAVIER. Apo.Manc.: WARRENCANO BRIAN;RIOS JIMENEZ MARIA CRISTINA;BERMEJO DEL VALLE CARLOS;CALLEJO RAMIRO PALOMA;LUZON GOMEZESTIBALIZ;FERNANDEZ SIMAL ANTOLIN MARIA JESUS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 61, S 8, H V 18297, I/A 111(14.10.16).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA BERRAL LUIS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 62, S 8, H V 18297, I/A 112 (14.10.16).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO;CASTROMARTINEZ ALVARO. Apo.Man.Soli: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO.

27 de Mayo de 2016
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 60, S 8, H V18297, I/A 110 (20.05.16).

15 de Febrero de 2016
Otros conceptos: Modificaci贸n y refundici贸n de Estatutos. Las modificaciones introducidas en los Estatutos sociales de la Sociedadtienen por finalidad adaptar su contenido a la normativa en vigor, en particular a la Ley 31/2014 de 3 de diciembre por la que semodifica la Ley de Sociedades de Capital. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 59, S 8, H V 18297, I/A 109 ( 8.02.16).

16 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO. Secretario: BROSETA DUPRE MANUEL ANDRES.Vicesecret.: RIOS NAVARRO ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: CASTRO MARTINEZ ALVARO. Secretario: CASTROMARTINEZ ALVARO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 58, S 8, H V 18297, I/A 108 ( 9.11.15).

02 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ REQUENA FERNANDO. Nombramientos. Consejero: YZAGUIRRE SCHARFHAUSENJORGE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 58, S 8, H V 18297, I/A 107 (25.09.15).

30 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MORRO MARTI MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 57, S 8, H V 18297, I/A 106 (23.04.15).

27 de Agosto de 2014
Modificaciones estatutarias. Modificacion de la retribucion del Organo de Administraci贸n. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 27,S 8, H V 18297, I/A 105 (20.08.14).

01 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: TORRE GONZALEZ ANGEL;ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Presidente: TORRE GONZALEZANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Nombramientos. Consejero:OLMOS IBA脩EZ VICENTE;DOMINGUEZ DE LA ROSA GABRIEL. Presidente: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Reelecciones.Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 103 (24.06.14).

Revocaciones. Apoderado: TORRE GONZALEZ ANGEL;TORRE GONZALEZ ANGEL;TORRE GONZALEZ ANGEL.Nombramientos. Apoderado: OLMOS IBA脩EZ VICENTE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 104(24.06.14).

25 de Junio de 2013
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V18297, I/A 102 (18.06.13).

16 de Octubre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VELA BARGUES JORGE. Nombramientos. Consejero: DIAZ REQUENA FERNANDO. Datosregistrales. T 4904, L 2213, F 55, S 8, H V 18297, I/A 101 ( 4.10.12).

07 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 54, S 8, H V 18297, I/A 100 (27.07.12).

01 de Agosto de 2012
Otros conceptos: Modificacion y refundicion de estatutos.ARTICULO 16 . COMPOSICION. 1. La direcci贸n, administraci贸n yrepresentaci贸n de la Sociedad corresponde al Consejo de Administraci贸n que estar谩 integrado por un m铆nimo de cinco y un m谩ximo desiete miembros, personas f铆sicas y cuyo n煤mero exacto se determinar谩por la junta General la cual habr谩 de. P谩gina web de lasociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.bolsavalencia.es. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 52, S 8, H V 18297,I/A 99 (23.07.12).

19 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO ALBEROLA JESUS. Nombramientos. Consejero: AMIGO SALMERON JULIOFRANCISCO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 52, S 8, H V 18297, I/A 98 ( 7.12.11).

25 de Octubre de 2011
Revocaciones. Apoderado: CASTRO MARTINEZ ALVARO;MORO MARTI MIGUEL ANGEL. Apo.Manc.: BLASCO ARGILES JOSEMIGUEL;MARTIN GARCIA JOSE LUIS;CASTRO MARTINEZ ALVARO;COSCOLLA LOPEZ BALBINA. Apoderado: COSCOLLALOPEZ BALBINA. Apo.Manc.: COSCOLLA LOPEZ BALBINA;AMIGO SALMERON JULIO FRANCISCO;CARSI CALVET VICENTE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORRO MARTI MIGUEL ANGEL;CASTRO MARTINEZ ALVARO;AMIGO SALMERON JULIOFRANCISCO. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 97 (14.10.11).

04 de Julio de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 96 (23.06.11).

28 de Febrero de 2011
Reelecciones. Consejero: NAVARRO ALBEROLA JESUS. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 95(17.02.11).

11 de Noviembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MALDONADO RUBIO JOAQUIN. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 94(29.10.10).

27 de Mayo de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 93 (18.05.10).

20 de Abril de 2010
Fe de erratas: Error al practicar la inscripci贸n en cuanto al cese del Consejero Don Benito Castillo Navarro, quedando estesubsistente. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 9 (25.11.09).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTILLO NAVARRO BENITO;TRIGO BEAUMONT AGUSTIN;PEREZ BOADA ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: VELA BARGUES JORGE. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 49, S 8, H V 18297, I/A 92 ( 9.04.10).

08 de Febrero de 2010
Revocaciones. Apoderado: GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Apo.Manc.: GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Apoderado:GALLEGO GONZALEZ ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: MORO MARTI MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 4904, L2213, F 47, S 8, H V 18297, I/A 91 (28.01.10).

04 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES Y RUMEU LUIS;CASTILLO NAVARROBENITO;TORRE GONZALEZ ANGEL. Presidente: TORRE GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL.Consejero: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Consejero: PEREZ BOADA ENRIQUE.Nombramientos. Consejero: BERMEJO RODRIGUEZ MARIA ISABEL;TORRE GONZALEZ ANGEL;ESCAMEZ SANCHEZMANUEL;PEREZ BOADA ENRIQUE. Presidente: TORRE GONZALEZ ANGEL. Vicepresid.: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL.Con.Delegado: ESCAMEZ SANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 9 (25.11.09).

19 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SUBIES MONTALAR FELIX. Otros conceptos: EL CONSEJO QUEDA FIJADO EN 9 MIEMBROS.Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 89 ( 9.06.09).

01 de Junio de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4904, L 2213, F 46, S 8, H V 18297, I/A 88 (21.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n