Buscador CIF Logo

Actos BORME Societat Daparcaments De Terrassa Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Societat Daparcaments De Terrassa Sa

Actos BORME Societat Daparcaments De Terrassa Sa - A61597183

Tenemos registrados 50 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Societat Daparcaments De Terrassa Sa con CIF A61597183

馃敊 Perfil de Societat Daparcaments De Terrassa Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Societat Daparcaments De Terrassa Sa

06 de Noviembre de 2023
Revocaciones. REPR.143 RRM: SANZ SANCHEZ ROSA. Nombramientos. REPR.143 RRM: MIRA CORTADELLAS MARIAANGELES. Datos registrales. T 47099 , F 43, S 8, H B 177720, I/A 76 (27.10.23).

04 de Julio de 2022
Nombramientos. CONSEJERO: DIEZ DIEZ JORDI;CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE TERRASSA. Datosregistrales. T 47099 , F 43, S 8, H B 177720, I/A 75 (27.06.22).

14 de Junio de 2022
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14BIS.- ASISTENCIA A LA JUNTA POR VIDEOCONFERENCIA U OTROS MEDIOSTELEMATICOS. Datos registrales. T 47099 , F 42, S 8, H B 177720, I/A 74 ( 7.06.22).

23 de Febrero de 2022
Revocaciones. SECR.NO CONS: MAZAS VIDAL DOLORS. Nombramientos. SECR.NO CONS: LAVADO FERNANDEZ NURIA.Datos registrales. T 47099 , F 42, S 8, H B 177720, I/A 73 (15.02.22).

07 de Mayo de 2021
Revocaciones. REPR.143 RRM: ANDREU ALMECIJA EMILIA. Nombramientos. REPR.143 RRM: SANZ SANCHEZ ROSA. Datosregistrales. T 47099 , F 42, S 8, H B 177720, I/A 72 (28.04.21).

04 de Enero de 2021
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES E INTRODUCCION A LOSMISMOS DEL ARTICULO 14 BIS. Datos registrales. T 47099 , F 41, S 8, H B 177720, I/A 71 (23.12.20).

Revocaciones. CONSEJERO: GARCIA LIZANDRA CARLOS. Nombramientos. CONSEJERO: SERRANO MARTINFRANCESC;PERREAU DE PINNINCK BALLESTA ALBERTO MARIA;MIRA CORTADELLAS MARIA ANGELS. Datos registrales. T47099 , F 41, S 8, H B 177720, I/A 70 (23.12.20).

19 de Noviembre de 2019
Revocaciones. REPR.143 RRM: CADEVALL ARTIGUES MARC. Nombramientos. REPR.143 RRM: ANDREU ALMECIJA EMILIA.Datos registrales. T 47099 , F 41, S 8, H B 177720, I/A 69 ( 8.11.19).

29 de Octubre de 2019
Revocaciones. REPR.143 RRM: FONT ROCA MIQUEL. Nombramientos. REPR.143 RRM: CASTELLO ESCUDE IGNASI. Datosregistrales. T 44338 , F 205, S 8, H B 177720, I/A 68 (16.10.19).

01 de Marzo de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.673.286,00 Euros. Datos registrales. T 44338 ,F 204, S 8, H B 177720, I/A 67 (22.02.19).

23 de Noviembre de 2018
Nombramientos. CONSEJERO: GARCIA LIZANDRA CARLOS;EGARVIA SA. Datos registrales. T 44338 , F 204, S 8, H B 177720,I/A 66 (15.11.18).

11 de Junio de 2018
Revocaciones. REPR.143 RRM: CANDELA LOPEZ EVA. Nombramientos. REPR.143 RRM: CADEVALL ARTIGUES MARC.Datos registrales. T 44338 , F 204, S 8, H B 177720, I/A 65 (31.05.18).

08 de Febrero de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.033.286,00 Euros. Datos registrales. T 44338 ,F 203, S 8, H B 177720, I/A 64 ( 1.02.18).

28 de Julio de 2017
Nombramientos. CONSEJERO: DIEZ DIEZ JORDI;CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE TERRASSA. Datosregistrales. T 44338 , F 203, S 8, H B 177720, I/A 63 (19.07.17).

25 de Abril de 2017
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ATRIBUCION DE CARACTERGRATUITO AL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 44338 , F 203, S 8, H B 177720, I/A 62 (13.04.17).

07 de Abril de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 720.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.393.286,00 Euros. Datos registrales. T 43474 ,F 80, S 8, H B 177720, I/A 61 (30.03.17).

08 de Febrero de 2017
Revocaciones. APODERAD.SOL: MARTINEZ VILA JOSEP. APOD.SOL/MAN: DIEZ DIEZ JORDI;ESPEJO MARIMON JOANMANEL;MARTI PEREZ AMADEO;GARCIA MARTIN JOSE MARIA;MADEU TOFFOLI CARLOTA;LLAURADO ALBA JORDI.Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARTINEZ VILA JOSEP;DIEZ DIEZ JORDI;PERREAU DE PINNINCK BALLESTAALBERTO;MARTI PEREZ AMADEO;GARCIA MARTIN JOSE MARIA;MASDEU TOFFOLI CARLOTA;LLAURADO ALBA JORDI. Datosregistrales. T 43474 , F 78, S 8, H B 177720, I/A 60 (31.01.17).

23 de Enero de 2017
Nombramientos. CONSEJERO: SERRANO MARTIN JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 43474 , F 78, S 8, H B 177720, I/A59 (16.01.17).

17 de Marzo de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.113.286,00 Euros. Datos registrales. T 43474 ,F 77, S 8, H B 177720, I/A 58 ( 9.03.16).

18 de Noviembre de 2015
Revocaciones. REPR.143 RRM: VEGA LOPEZ ALFREDO. Nombramientos. REPR.143 RRM: CANDELA LOPEZ EVA. Datosregistrales. T 43474 , F 77, S 8, H B 177720, I/A 57 (10.11.15).

25 de Mayo de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 180.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.473.286,00 Euros. Datos registrales. T 43474 ,F 76, S 8, H B 177720, I/A 55 (15.05.15).

Revocaciones. CONSEJERO: MORALES FERNANDEZ ALFREDO. Nombramientos. CONSEJERO: PERREAU DE PINNINCKBALLESTA ALBERTO MARIA. Datos registrales. T 43474 , F 77, S 8, H B 177720, I/A 56 (15.05.15).

23 de Abril de 2015
Revocaciones. REPR.143 RRM: LABORIA ROJAS CARME. Nombramientos. REPR.143 RRM: VEGA LOPEZ ALFREDO. Datosregistrales. T 43474 , F 76, S 8, H B 177720, I/A 54 (15.04.15).

06 de Abril de 2015
Revocaciones. APODERADO: MARTINEZ VILA JOSEP;DIEZ DIEZ JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;MARTI PEREZAMADEO;GARCIA MARTIN JOSE MARIA;MASDEU TOFFOLI CARLOTA;PEREZ CEBRIAN RICARD. Nombramientos.APODERAD.SOL: MARTINEZ VILA JOSEP. APOD.SOL/MAN: DIEZ DIEZ JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;MARTI PEREZAMADEO;GARCIA MARTIN JOSE MARIA;MADEU TOFFOLI CARLOTA;LLAURADO ALBA JORDI. Datos registrales. T 43474 , F74, S 8, H B 177720, I/A 53 (25.03.15).

23 de Abril de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.653.286,00 Euros. Datos registrales. T 43474 ,F 73, S 8, H B 177720, I/A 52 (11.04.14).

04 de Abril de 2014
Revocaciones. APODERADO: BONET VENDRELL JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;JIMENEZ ESPEJO MARIA PILAR.Datos registrales. T 43474 , F 73, S 8, H B 177720, I/A 50 (27.03.14).

Revocaciones. CONSEJERO: ESPEJO MARIMON JOAN MANEL. Nombramientos. CONSEJERO: MORALES FERNANDEZALFREDO. Datos registrales. T 43474 , F 73, S 8, H B 177720, I/A 51 (27.03.14).

22 de Octubre de 2013
Nombramientos. CONSEJERO: EGARVIA SA. Datos registrales. T 43474 , F 73, S 8, H B 177720, I/A 48 (15.10.13).

Revocaciones. APODERADO: CORONAS GUINART JOSE MARIA;DIEZ DIEZ JORDI;FORNESA REBES RICARD;MORALESFERNANDEZ ALFREDO;NIETO PULIDO ANTONIA;PERREAU DE PINNINCK BALLESTA ALBERTO MARIA;SANANTON SANCHEZALBERTO JOSE;SERRANO MARTIN JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 43474 , F 73, S 8, H B 177720, I/A 49 (15.10.13).

02 de Agosto de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: BALLART PASTOR JORDI. VICEPRESIDEN: BALLART PASTOR JORDI. Nombramientos.CONSEJERO: GARCIA LIZANDRA CARLOS. Datos registrales. T 43474 , F 72, S 8, H B 177720, I/A 47 (26.07.13).

05 de Junio de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.013.286,00 Euros. Datos registrales. T 43474 ,F 72, S 8, H B 177720, I/A 46 (29.05.13).

08 de Mayo de 2013
Nombramientos. CONSEJERO: DIEZ DIEZ JORDI;CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DE TERRASSA. REPR.143 RRM:FONT ROCA MIQUEL. Datos registrales. T 43474 , F 71, S 8, H B 177720, I/A 45 (26.04.13).

10 de Abril de 2013
Revocaciones. REPR.143 RRM: COLOMER ESPINET JOSEP MIQUEL. Nombramientos. REPR.143 RRM: LABORIA ROJASCARME. Datos registrales. T 43474 , F 71, S 8, H B 177720, I/A 44 (28.03.13).

19 de Noviembre de 2012
Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ VILA JOSEP;DIEZ DIEZ JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;MARTI PEREZAMADEO;GARCIA MARTIN JOSE MARIA;MASDEU TOFFOLI CARLOTA;PEREZ CEBRIAN RICARD. Datos registrales. T 42025 , F118, S 8, H B 177720, I/A 43 ( 6.11.12).

23 de Abril de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.373.286,00 Euros. Datos registrales. T 42025 ,F 117, S 8, H B 177720, I/A 42 (12.04.12).

10 de Enero de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: MELGARES AGUIRRE LUISA. VICEPRESIDEN: MELGARES AGUIRRE LUISA. Nombramientos.CONSEJERO: BALLART PASTOR JORDI. VICEPRESIDEN: BALLART PASTOR JORDI. Datos registrales. T 42025 , F 117, S 8, HB 177720, I/A 41 (29.12.11).

06 de Septiembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: MARGENAT PADROS JOAN ARTUR;DIEZ DIEZ JORDI;FORNESA REBES RICARD;BONETVENDRELL JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;JIMENEZ ESPEJO MARIA PILAR;LOPEZ BECERRA JOSEANTONIO;MORALES FERNANDEZ ALFREDO;NIETO PULIDO ANTONIA;PERREAU DE PINNINCK BALLESTA ALBERTOMARIA;PUJOL XICOY GIMFERRER JORDI;SANANTON SANCHEZ ALBERTO JOSE;SERRANO MARTIN JUAN FRANCISCO.Datos registrales. T 42025 , F 116, S 8, H B 177720, I/A 40 (24.08.11).

12 de Mayo de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.733.286,00 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 22.- CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 42025 , F 115, S 8, H B 177720, I/A 39 ( 2.05.11).

01 de Febrero de 2011
Nombramientos. APODERADO: DIEZ DIEZ JORDI;FORNESA REBES RICARD;BONET VENDRELL JORDI;ESPEJO MARIMONJOAN MANEL;JIMENEZ ESPEJO MARIA PILAR;MORALES FERNANDEZ ALFREDO;NIETO PULIDO ANTONIA;PERREAU DEPINNINCK BALLESTA ALBERTO MARIA;SANATON SANCHEZ ALBERTO JOSE;SERRANO MARTIN JUAN FRANCISCO. Datosregistrales. T 42025 , F 113, S 8, H B 177720, I/A 38 (24.01.11).

04 de Agosto de 2010
Revocaciones. CONSEJERO: CANOS CIURANA JOSEP. PRESIDENTE: CANOS CIURANA JOSEP. CONSEJERO: PUJOL XICOYGIMFERRER JORDI. Nombramientos. CONSEJERO: SERRANO MARTIN JUAN FRANCISCO. PRESIDENTE: DIEZ DIEZ JORDI.CONSEJERO: ESPEJO MARIMON JOAN MANEL. Datos registrales. T 38861 , F 39, S 8, H B 177720, I/A 35 (23.07.10).

Revocaciones. APODERADO: CANOS CIURANA JOSEP;DIEZ DIEZ JORDI. Nombramientos. APODERADO: DIEZ DIEZJORDI;FORNESA REBES RICARD;BONET VENDRELL JORDI;ESPEJO MARIMON JOAN MANEL;JIMENEZ ESPEJO MARIAPILAR;LOPEZ BECERRA JOSE ANTONIO;MORALES FERNANDEZ ALFREDO;NIETO PULIDO ANTONIA;PERREAU DE PINNINCKBALLESTA ALBERTO MARIA;PUJOL XICOY GIMFERRER JORDI;SANANTON SANCHEZ ALBERTO JOSE;SERRANO MARTINJUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 38861 , F 40, S 8, H B 177720, I/A 36 (23.07.10).

Nombramientos. APODERADO: CORONAS GUINART JOSE MARIA. Datos registrales. T 42025 , F 113, S 8, H B 177720, I/A 37(23.07.10).

26 de Abril de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.093.286,00 Euros. Datos registrales. T 38861 ,F 39, S 8, H B 177720, I/A 34 (13.04.10).

08 de Febrero de 2010
Revocaciones. CONSEJERO: IGLESIAS FRESQUET TOMAS. Nombramientos. CONSEJERO: PUJOL XICOY GIMFERRERJORDI. Datos registrales. T 38861 , F 38, S 8, H B 177720, I/A 33 (27.01.10).

08 de Julio de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: PRUNES SANTAMARIA ANTONI. Nombramientos. CONSEJERO: EGARVIA SA. REPR.143 RRM:COLOMER ESPINET JOSEP MIQUEL. Datos registrales. T 38861 , F 38, S 8, H B 177720, I/A 32 (26.06.09).

22 de Junio de 2009
Revocaciones. PRESIDENTE: FONT ALEGRET JOAN. CONSEJERO: FONT ALEGRET JOAN. Nombramientos. CONSEJERO:CANOS CIURANA JOSEP. PRESIDENTE: CANOS CIURANA JOSEP. Datos registrales. T 38861 , F 35, S 8, H B 177720, I/A 28 (9.06.09).

Nombramientos. APODERADO: MARGENAT PADROS JOAN ARTUR. Datos registrales. T 38861 , F 35, S 8, H B 177720, I/A 29 (9.06.09).

Revocaciones. APODERADO: FONT ALEGRET JOAN;DIEZ DIEZ JORDI. Nombramientos. APODERADO: CANOS CIURANAJOSEP;DIEZ DIEZ JORDI. Datos registrales. T 38861 , F 35, S 8, H B 177720, I/A 30 ( 9.06.09).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 360.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.453.286,00 Euros. Datos registrales. T 38861 ,F 37, S 8, H B 177720, I/A 31 ( 9.06.09).

22 de Mayo de 2009
Otros conceptos: RECTIFICADA LA INS.24,BORME 115/08,REFERENCIA 304506,POR CUANTO SE OMITIO POR ERRORMATERIAL DE TRANSCRIPCION LA REELECCION COMO CONSEJERO DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERC I INDUSTRIA DETERRASSA POR UN PLAZO DE CINCO A脩OS. Datos registrales. T 38861 , F 34, S 8, H B 177720, I/A 27 (11.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n