Buscador CIF Logo

Actos BORME Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl

Actos BORME Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl - B65455487

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl con CIF B65455487

馃敊 Perfil de Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Socima Sociedad Industrial De Matriceria Sl

16 de Octubre de 2023
Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO54/2023, AUTO FIRME DE FECHA 14/09/2023, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LASOCIEDAD. Datos registrales. T 42278 , F 134, S 8, H B 406544, I/A 20 ( 6.10.23).

14 de Septiembre de 2023
Otros conceptos: JUZGADO SOCIAL N- 30 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023,DECLARACION DE INSOLVENCIA. Datos registrales. T 42278 , F 134, S 8, H B 406544, I/A 19 ( 7.09.23).

26 de Julio de 2023
Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO54/2023, AUTO FIRME DE FECHA 15/06/2023, POR EL QUE SE ACUERDA LA FINALIZACION DE LA FASE COMUN DELCONCURSO. Datos registrales. T 42278 , F 133, S 8, H B 406544, I/A 18 (19.07.23).

04 de Mayo de 2023
Revocaciones. ADM.UNICO: FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 54/2023, AUTO FIRME DE FECHA 15/03/2023, APERTURA DE LAFASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 42278 , F 133, S 8, H B 406544, I/A 17(25.04.23).

21 de Febrero de 2023
Nombramientos. ADM.CONCURS.: CONDITIO CREDITORUM CONCURSAL SLP. REP.ADM.CONC: LOPEZ RIVAS EDGAR.Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO54/2023, AUTO FIRME DE FECHA 12/01/2023, SUBSANADO POR AUTO DE FECHA 13/01/2023, DECLARACION DE CONCURSOVOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 42278 , F 132, S 8, H B 406544, I/A 16 (14.02.23).

21 de Abril de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 712.209,00 Euros. Datos registrales. T 42278 , F 132, S 8,H B 406544, I/A 15 (12.04.21).

28 de Agosto de 2019
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42278 , F 131, S 8, H B406544, I/A 14 (20.08.19).

29 de Noviembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 514.000,00 Euros. Datos registrales. T 42279 , F 130, S 8,H B 406544, I/A 12 (22.11.18).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.791,00 Euros. Resultante Suscrito: 512.209,00 Euros. Datos registrales. T 42278 , F131, S 8, H B 406544, I/A 13 (22.11.18).

18 de Julio de 2016
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONTMESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42278 , F 130, S 8, H B 406544, I/A 11 (11.07.16).

22 de Abril de 2016
Nombramientos. APODERAD.SOL: FERNANDEZ FERNANDEZ MAITE;FERNANDEZ FERNANDEZ SUSANA;FERNANDEZFERNANDEZ OSCAR. Datos registrales. T 42278 , F 130, S 8, H B 406544, I/A 10 (14.04.16).

14 de Abril de 2016
Revocaciones. ADM.UNICO: FERYFER ASOCIADOS SL. REPR.143 RRM: FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Nombramientos.ADM.UNICO: FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.221,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.000,00Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 12: JUNTA GENERAL. ARTICULO 19: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANODE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 42278 , F 129, S 8, H B 406544, I/A 9 ( 6.04.16).

18 de Enero de 2016
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42278 , F 129, S 8, H B406544, I/A 8 ( 8.01.16).

10 de Septiembre de 2015
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: MATEU GARCIA MANUEL;FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Nombramientos. ADM.UNICO:FERYFER ASOCIADOS SL. REPR.143 RRM: FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DELOS ARTICULOS 12,15,16,19,28 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DEJANDO SIN CONTENIDO EL ARTICULO 20 DE LOSMISMOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 42278 , F 128, S 8, H B 406544, I/A 7 (27.08.15).

05 de Agosto de 2015
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: ESCUDERO LOPEZ ANTONIO. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: FERNANDEZ GONZALEZCELSO. Datos registrales. T 42278 , F 128, S 8, H B 406544, I/A 6 (29.07.15).

22 de Octubre de 2014
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROC. ORDINARIO 573/2013,SENTENCIA FIRME DE17/03/2014,DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE 30/06/2011, EN CONSECUENCIA, SE CANCELA ELDEPOSITO NUMERO 33014041 DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2010. Datos registrales. T 42278 , F 127, S 8, H B 406544, I/A4 (14.10.14).

Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 6 BARCELONA, PROC. ORDINARIO 574/2013,SENTENCIA FIRME DE17/03/2014,DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA DE 30/06/2012, EN CONSECUENCIA, SE CANCELA ELDEPOSITO NUMERO 33014042 DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2011. Datos registrales. T 42278 , F 128, S 8, H B 406544, I/A5 (14.10.14).

03 de Julio de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42278 , F 127, S 8, H B406544, I/A 3 (25.06.13).

09 de Mayo de 2013
Revocaciones. ADM.CONJUNTO: FERNANDEZ GONZALEZ CELSO. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: ESCUDERO LOPEZANTONIO;MATEU GARCIA MANUEL. Modificaciones estatutarias. ARTS.15 Y 16.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42278 , F 126, S 8, H B 406544, I/A 2 ( 2.05.13).

12 de Enero de 2011
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.11.10. Objeto social: PROYECTO, CONSTRUCCION, REPARACION Y VENTA DEMATRICES, EN SU MAS AMPLIO SENTIDO, TECNOLOGICO, UTILES DE MECANIZACION, UTILLAJES, AUTOMATISMOS,LOGOTIPOS, ENSAMBLAJES Y MAQUINARIA EN GENERAL. DISE脩O, CONSTRUCCION Y VENTA ETC. Domicilio: CL PARISNUMERO 12 POLIGONO IND. COVA SOLERA (RUBI). Capital: 3.779,00 Euros. Nombramientos. ADM.CONJUNTO: FERNANDEZGONZALEZ CELSO;ESCUDERO LOPEZ ANTONIO;MATEU GARCIA MANUEL. Datos registrales. T 42278 , F 122, S 8, H B406544, I/A 1 (29.12.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n