Actos BORME de Sodemerca Sociedad Anonima
13 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Liquidador: DENIS CHEVALLIER REMY PAUL. Adm. Unico: DENIS CHEVALLIER REMY PAUL. Revocaciones.Apo.Man.Soli: TRUCHON-BARTES CYRIL. Apoderado: SANCHEZ PEREA LEIRE;VIDAL BALCELLS MARTA;GOMEZ ANGELATSLUIS. Nombramientos. Liquidador: DENIS CHEVALLIER REMY PAUL. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T962, L 726, F 212, S 8, H AB 25135, I/A 4 ( 5.12.18).
23 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LAMBRE DOMINIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: DENIS CHEVALLIER REMY PAUL. Datosregistrales. T 962, L 726, F 212, S 8, H AB 25135, I/A 3 (15.03.17).
24 de Diciembre de 2015Cambio de domicilio social. CTRA NACIONAL 330 Km 1,5 (ALMANSA). Datos registrales. T 962, L 726, F 212, S 8, H AB 25135,I/A 22 (17.12.15).
05 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ANGELATS LUIS;VIDAL BALCELLS MARTA;SANCHEZ PEREA LEIRE. Datos registrales. T1922 , F 96, S 8, H T 5386, I/A 32 (29.08.13).
Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ ANGELATS LUIS. Consejero: LUREAU CHRISTIAN;CONAN PIERRE YVES;STAELENSMARTIN;LAMBRE DOMINIQUE. Presidente: LAMBRE DOMINIQUE. Nombramientos. Adm. Unico: LAMBRE DOMINIQUE.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otrosconceptos: Modificados los art铆culos 1,5,13,14,15,17,20,22,23,24,26,27,28,29,30,32 y 36 de los Estatutos sociales. Datosregistrales. T 1922 , F 97, S 8, H T 5386, I/A 33 (29.08.13).
12 de Marzo de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: YAGUE MARTIN ARTURO. Datos registrales. T 1922 , F 96, S 8, H T 5386, I/A 31 (24.02.12).
14 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: MAZEROLLE PHILIPPE. Apo.Manc.: PEREZ SEBASTIEN JEAN CLAUDE. Apo.Sol.: PEREZSEBASTIEN JEAN CLAUDE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: YAGUE MARTIN ARTURO;TRUCHON-BARTES CYRIL. Datosregistrales. T 1922 , F 95, S 8, H T 5386, I/A 30 (30.11.10).
01 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MAZEROLLE PHILIPPE;PEREZ SEBASTIEN JEAN CLAUDE;FONTANILS EMILE JOSE JULES.Secretario: FONTANILS EMILE JOSE JULES. Presidente: PEREZ SEBASTIEN JEAN CLAUDE. Nombramientos. Secretario:GOMEZ ANGELATS LUIS. Consejero: LUREAU CHRISTIAN;CONAN PIERRE YVES;STAELENS MARTIN;LAMBRE DOMINIQUE.Presidente: LAMBRE DOMINIQUE. Datos registrales. T 1922 , F 94, S 8, H T 5386, I/A 29 (18.11.10).