Actos BORME de Sogaserso Sa
05 de Junio de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUANJOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Datosregistrales. T 3732, L 3732, F 122, S 8, H PO 51791, I/A 8 (28.05.19).
17 de Enero de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: RESGAL VIGO SL. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 122, S 8, H PO 51791, I/A7 (10.01.17).
28 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: AGUILAR LOPEZ MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ GORDON ROMAN;GUTIERREZ AMOROS MARIADEL ROSARIO;ALVAREZ ACEVEDO ALFONSO. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 121, S 8, H PO 51791, I/A 6 (18.11.16).
24 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ POLICARPO SANZ 24-26 (VIGO). Datos registrales. T 3732, L 3732, F 121, S 8, H PO 51791, I/A 5(16.04.15).
09 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTRO SEOANE MARIA DIGNA. Nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSELUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nicoa Administradores mancomunados. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 121, S 8, H PO 51791, I/A 4 (25.04.12).
19 de Diciembre de 2011Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CAIXA DE AFORROS DE GALICIA VIGO OURENSE E PONTEVE. Datosregistrales. T 3732, L 3732, F 120, S 8, H PO 51791, I/A 3 ( 5.12.11).
14 de Septiembre de 2011Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 1-3 (VIGO). Datos registrales. T 3732, L 3732, F 110, S 8, H PO 51791, I/A1 (31.08.11).
Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 4潞 de los Estatutos Sociales, correspondiente al domicilio social. Datos registrales. T 3732,L 3732, F 120, S 8, H PO 51791, I/A 2 (31.08.11).
23 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: MAZAIRA CASTRO ANDRES. Datos registrales. T 810 , F 70, S 8, H OR 10799, I/A 16 (29.07.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RESGAL FERROLTERRA SL;RESGAL CORU脩A SL;CASTRO SEOANE MARIA DIGNA;SANCHEZGORDON ROMAN;VARELA MIRAGAYA MARIA JESUS. Presidente: RESGAL FERROLTERRA SL. Secretario: SANTODOMINGOFOULQUIE IRIA. Consejero: RESGAL VIGO SL. Nombramientos. Adm. Unico: CASTRO SEOANE MARIA DIGNA. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Otros conceptos: Adaptadoslos Estatutos Sociales al Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprob贸 el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ymodificados los art铆culos 1,34,15y 33 de los Estatutos Sociales y suprimidos los art铆culos 9y el p谩rrafo segundo del art铆culo 10 de losEstatutosSe modifican los art铆culos 23 a 30 de los Estatutos Sociales y se da nueva redacci贸n a los art铆culos 10,11,19, 20 y 33 , todoello como consecuencia del cambio de sistema de administraci贸n. Datos registrales. T 810 , F 70, S 8, H OR 10799, I/A 17 (29.07.11).
29 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ GORDON ROMAN. Datos registrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 10799, I/A 15 (18.03.11).
01 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 8.000.000,00 Euros. Desembolsado: 8.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 18.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 10799, I/A 14 (14.01.11).
28 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ ACEVEDO ALFONSO;GUTIERREZ AMOROS MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T736 , F 66, S 8, H OR 10799, I/A 12 (17.12.10).
Revocaciones. Apoderado: MAZAIRA CASTRO ANDRES. Nombramientos. Apoderado: AGUILAR LOPEZ MANUEL. Datosregistrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 10799, I/A 13 (17.12.10).
16 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 736 , F 66, S 8, H OR 10799, I/A 11 (1.12.10).
11 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ SACRISTAN MARIA VICTORIA;GUTIERREZ OIS JUAN MANUEL;RESGALFERROLTERRA SL;RESGAL VIGO SL. Presidente: MATO OTERO BEATRIZ. Consejero: MATO OTERO BEATRIZ;LOPEZ ABELLASUSANA;PI脩EIRO VAZQUEZ CORO;PEDROSA PEDROSA ROSA MARIA;COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA;VARELAMIRAGAYA MARIA JESUS;RESGAL CORU脩A SL. Miem.Com.Ej.: GUTIERREZ OIS JUAN MANUEL. Secretario: ORTIZ DORDACRISTINA. Nombramientos. Consejero: RESGAL FERROLTERRA SL;RESGAL CORU脩A SL;CASTRO SEOANE MARIADIGNA;SANCHEZ GORDON ROMAN;VARELA MIRAGAYA MARIA JESUS. Presidente: RESGAL FERROLTERRA SL. Secretario:SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA. Consejero: RESGAL VIGO SL. Otros conceptos: Modificaci贸n el art铆culo 7 de los EstatutosSociales referente a que dicho art铆culo queda sin contenido y del art铆culo 23 relativo a que el Consejo de Administraci贸n se compondr谩de un n煤mero de miembros que determine la Junta General, conun m铆nimo de 3 y un m谩ximo de 12 consejeros. Cambio de objetosocial. a) La construcci贸n, equipamiento, gesti贸n directa e indirecta y el arrendamiento de toda clase de infraestructuras f铆sicasdestinadas a todas las actividades de acci贸n y/o asistencia social y prestaci贸n de servicios sociales. b) La promoci贸n, dise帽o, ejecuci贸ny gesti贸n. Datos registrales. T 736 , F 65, S 8, H OR 10799, I/A 10 (25.10.10).
15 de Enero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTANA GONZALEZ ANXO MANUEL;LAGO VILABOA MARIA JESUS;SEARA FORMOSO XOSEBIEITO;VI脩A CARREGAL INMACULADA. Presidente: QUINTANA GONZALEZ ANXO MANUEL. Miem.Com.Ej.: SEARA FORMOSOXOSE BIEITO. Consejero: FERREIRA FERNANDEZ ANTONIO XAVIER. Secretario: FERREIRA FERNANDEZ ANTONIO XAVIER.Nombramientos. Consejero: MATO OTERO BEATRIZ;LOPEZ ABELLA SUSANA;PI脩EIRO VAZQUEZ CORO;PEDROSA PEDROSAROSA MARIA;COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA;VARELA MIRAGAYA MARIA JESUS;RESGAL CORU脩A SL. Datosregistrales. T 736 , F 65, S 8, H OR 10799, I/A 8 (24.12.09).
Nombramientos. Presidente: MATO OTERO BEATRIZ. Secretario: ORTIZ DORDA CRISTINA. Datos registrales. T 736 , F 65, S 8,H OR 10799, I/A 9 (24.12.09).
13 de Abril de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.400.000,00 Euros. Desembolsado: 5.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.500.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 10.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 736 , F 65, S 8, H OR 10799, I/A 7 (26.03.09).