Buscador CIF Logo

Actos BORME Sogeur Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sogeur Sa

Actos BORME Sogeur Sa - A59053702

Tenemos registrados 13 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Sogeur Sa con CIF A59053702

馃敊 Perfil de Sogeur Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Sogeur Sa

02 de Agosto de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. CONS.DELEG.: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER;RAMOS SANCHEZMIGUEL ANGEL. VICEPRESIDEN: RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL. SECR.NO CONS: PRAT CASTELLA XAVIER.LIQUIDADOR: PRAT CASTELLA XAVIER. Nombramientos. LIQUIDADOR: PRAT CASTELLA XAVIER. Extinci贸n. Datosregistrales. T 44161 , F 95, S 8, H B 71329, I/A 31 (24.07.18).

27 de Noviembre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 281.328,10 Euros. Resultante Suscrito: 60.039,90 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: SOLUCIONS I GESTIO D'HABITATGES SL. Datos registrales. T 44161 , F 93, S 8, H B 71329, I/A 30(19.11.15).

05 de Noviembre de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 259.632,00 Euros. Resultante Suscrito: 341.368,00 Euros. Escisi贸n parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisi贸n: NOVA OFITEC SL. Datos registrales. T 44161 , F 91, S 8, H B 71329, I/A 29 (28.10.15).

03 de Febrero de 2015
Cambio de domicilio social. CL ALMOGAVERS,199, LOCAL (BARCELONA). Datos registrales. T 44161 , F 91, S 8, H B 71329,I/A 28 (23.01.15).

30 de Enero de 2014
Revocaciones. APODERADO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO;LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. Datosregistrales. T 39279 , F 110, S 8, H B 71329, I/A 27 (21.01.14).

29 de Enero de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL;RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOSSANCHEZ JOSE ANTONIO. CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. VICEPRESIDEN: LOIZU FERNANDEZREINOSO MAXIMO JAVIER. CONS. DELEG.: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. Nombramientos. CONSEJERO:RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. CONS. DELEG.: RAMOS SANCHEZJOSE ANTONIO. CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER;RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL.VICEPRESIDEN: RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL. SECR.NO CONS: PRAT CASTELLA XAVIER. Otros conceptos:AUTORIZACION A LOS ADMINISTRADORES PARA QUE PUEDAN DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO,ANALOGO O COMPLEMENTARIO GENERO DE ACTIVIDAD QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. Datos registrales. T 39279, F 108, S 8, H B 71329, I/A 25 (21.01.14).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. APOD.MANCOMU: PRAT CASTELLAXAVIER. Datos registrales. T 39279 , F 109, S 8, H B 71329, I/A 26 (21.01.14).

14 de Noviembre de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO.CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. VICEPRESIDEN: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMOJAVIER. CONS. DELEG.: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. CONSEJERO: DIAZ RUIZ JOSE MARIA MANUEL.SECRETARIO: DIAZ RUIZ JOSE MARIA MANUEL. Nombramientos. CONSEJERO: RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL;RAMOSSANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSOMAXIMO JAVIER. VICEPRESIDEN: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. CONS. DELEG.: LOIZU FERNANDEZREINOSO MAXIMO JAVIER. SECR.NO CONS: PRAT CASTELLA XAVIER. Datos registrales. T 39279 , F 107, S 8, H B 71329, I/A24 (31.10.11).

29 de Septiembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 29.328,80 Euros. Resultante Suscrito: 571.671,20 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 29.328,80 Euros. Desembolsado: 29.328,80 Euros. Resultante Suscrito: 601.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:601.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 5.-RENUMERACION DE LAS ACCIONES. Datos registrales. T 39279, F 105, S 8, H B 71329, I/A 23 (20.09.11).

02 de Agosto de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SOLIGESTIO SA. Datos registrales. T 39279 , F 104, S 8, H B 71329, I/A 22(21.07.11).

17 de Junio de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: CAT 89 GRUP AUDIT SLP. Datos registrales. T 39279 , F 103, S 8, H B 71329, I/A 21 ( 8.06.11).

24 de Agosto de 2009
Nombramientos. CONSEJERO: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO. PRESIDENTE: RAMOS SANCHEZ JOSE ANTONIO.CONSEJERO: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. VICEPRESIDEN: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMOJAVIER. CONS. DELEG.: LOIZU FERNANDEZ REINOSO MAXIMO JAVIER. CONSEJERO: DIAZ RUIZ JOSE MARIA MANUEL.SECRETARIO: DIAZ RUIZ JOSE MARIA MANUEL. Datos registrales. T 39279 , F 102, S 8, H B 71329, I/A 20 (11.08.09).

21 de Enero de 2009
Cambio de domicilio social. PZ SANT AGUSTI VELL 2-4, LOCAL (BARCELONA). Datos registrales. T 39279 , F 101, S 8, H B71329, I/A 19 ( 7.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n