Actos BORME de Sol Y Tierra Campo De Cartagena Sl
20 de Octubre de 2023Otros conceptos: Se crea un nuevo artículo social, en concreto el número 18 bis.- Datos registrales. T 3498 , F 63, S 8, H MU40727, I/A 52 ( 6.10.23).
24 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: JUAN LUIS SANCHEZ GARRE. Datos registrales. T 3498 , F 62, S 8, H MU 40727, I/A 50 (17.08.23).
Nombramientos. Apo.Manc.: ISABEL-MARIA MERCADER PEREZ;CONSUELO VIDAL ROS;MARIA GINESA ZAPATA MARTINEZ.Datos registrales. T 3498 , F 62, S 8, H MU 40727, I/A 51 (17.08.23).
22 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SANDRA SANCHEZ CASTILLO. Datos registrales. T 3498 , F 62, S 8, H MU 40727, I/A 49 (10.08.23).
16 de Agosto de 2023Otros conceptos: Se modifica el párrafo segundo del artículo 11º de los estatutos sociales.- Datos registrales. T 3498 , F 62, S 8, HMU 40727, I/A 48 ( 8.08.23).
29 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;JOSE GARCIA MARIN;FRANCISCO-JOSE PAREDESGARRE;JOSE MANUEL MARTOS GARCIA;PEDRO SOTO PEDREÑO;JOSE SOTO GAZQUEZ;MATIAS TORRES JIMENEZ;JOSELUIS SANCHEZ LAMBERTO;JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ. Presidente: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE.Secretario: JOSE GARCIA MARIN. Vicepresid.: FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE. Tesorero: PEDRO SOTO PEDREÑO.Cons.Del.Man: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;JOSE GARCIA MARIN;FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE;PEDROSOTO PEDREÑO;JOSE MANUEL MARTOS GARCIA. Nombramientos. Consejero: JOSE GARCIA MARIN;FRANCISCO-JOSEPAREDES GARRE;PEDRO SOTO PEDREÑO;JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ;ANGEL PEÑALVER ROS;MARIANOALBALADEJO SAEZ;FRANCISCO MARIN MARTINEZ;ALBERTO SALINEAS MARTINEZ;JUAN-JOSE LOPEZ DE-GEA. Presidente:JOSE GARCIA MARIN. Secretario: FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE. Vicepresid.: PEDRO SOTO PEDREÑO. Tesorero: JOSEANTONIO MARTINEZ SANCHEZ. Cons.Del.Man: JOSE GARCIA MARIN;FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE;PEDRO SOTOPEDREÑO;JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ. Datos registrales. T 3498 , F 61, S 8, H MU 40727, I/A 47 (21.12.22).
21 de Julio de 2022Otros conceptos: Modificación del párrafo segundo del artículo 11 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 3498 , F 61, S 8, HMU 40727, I/A 46 (14.07.22).
11 de Marzo de 2022Nombramientos. Auditor: COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES SOCIEDA. Datos registrales. T 3498 , F 60, S8, H MU 40727, I/A 45 ( 4.03.22).
25 de Agosto de 2021Otros conceptos: Se modifica el párrafo segundo del artículo 11º y el artículo 14º de los Estatutos Sociales.- Datos registrales. T3498 , F 60, S 8, H MU 40727, I/A 44 (18.08.21).
25 de Mayo de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: SANDRA SANCHEZ CASTILLO;CONSUELO VIDAL ROS;MARIA GINESA ZAPATA MARTINEZ.Datos registrales. T 3001 , F 10, S 8, H MU 40727, I/A 42 (18.05.20).
07 de Agosto de 2019Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS. Datos registrales. T 3001 , F 9, S 8, H MU 40727,I/A 41 (31.07.19).
18 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: JUANA BAÑOS LEGAZ;FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE;JOSE GARCIA MARIN;SANTIAGOALBALADEJO MEROÑO;JOSE MANUEL MARTOS GARCIA;ANTONIO GALINDO GARCIA;MANUEL RODRIGUEZGUILLEN;EUSEBIO CARRASCO VERA;PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Vicepresid.: EUSEBIO CARRASCO VERA.Cons.Del.Man: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;EUSEBIO CARRASCO VERA;JUANABAÑOS LEGAZ. Presidente: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Secretario: JOSE GARCIA MARIN. Cons.Del.Man: JOSEGARCIA MARIN. Nombramientos. Consejero: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;JOSE GARCIA MARIN;FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE;JOSE MANUEL MARTOS GARCIA;PEDRO SOTO PEDREÑO;JOSE SOTO GAZQUEZ;MATIAS TORRES
11 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES SOCIEDA. Datos registrales. T 3001 , F 9, S 8,H MU 40727, I/A 39 ( 4.07.18).
10 de Julio de 2018Otros conceptos: MODIFICACION ARTICULOS 5, 6 Y 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3001 , F 8, S 8,H MU 40727, I/A 38 ( 3.07.18).
03 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: ANTONIO GALINDO GARCIA. Cons.Del.Man: ANTONIO GALINDO GARCIA. Secretario: PEDROFERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Nombramientos. Presidente: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Secretario: JOSEGARCIA MARIN. Cons.Del.Man: JOSE GARCIA MARIN. Datos registrales. T 3001 , F 8, S 8, H MU 40727, I/A 37 (27.07.17).
26 de Julio de 2017Otros conceptos: Modifican el parrafo segundo del articulo 11 de los EStatutos Sociales. Datos registrales. T 3001 , F 8, S 8, H MU40727, I/A 36 (19.07.17).
03 de Noviembre de 2016Nombramientos. Cons.Del.Man: JUANA BAÑOS LEGAZ. Datos registrales. T 3001 , F 7, S 8, H MU 40727, I/A 35 (25.10.16).
29 de Agosto de 2016Ampliación de capital. Capital: 12.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.505.000,00 Euros. Otros conceptos: SE MODIFICA ELPARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3001 , F 7, S 8, H MU 40727, I/A34 (22.08.16).
26 de Enero de 2016Otros conceptos: Modificación del párrafo segundo del articulo 11, y del primer párrafo del apartado g) del articulo 6, de los estatutossociales. Datos registrales. T 3001 , F 6, S 8, H MU 40727, I/A 33 (19.01.16).
16 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES SOCIEDA. Datos registrales. T 3001 , F 6, S 8, HMU 40727, I/A 32 ( 9.09.15).
06 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO GALINDO GARCIA;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;JOSE ANGEL DIAZSANCHEZ;ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA;JUAN JOSE ALBALADEJO GARRE;EUSEBIO CARRASCO VERA;PEDROFERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;DIEGO ANTONIO GARCIA GARCIA. Presidente: ANTONIO GALINDO GARCIA. Secretario:ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA. Vicepresid.: JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ. Cons.Del.Man: ANTONIO GALINDOGARCIA;JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ;ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;PEDROFERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Tesorero: MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN. Nombramientos. Consejero: JUANA BAÑOSLEGAZ;FRANCISCO-JOSE PAREDES GARRE;JOSE GARCIA MARIN;SANTIAGO ALBALADEJO MEROÑO;JOSE MANUELMARTOS GARCIA;ANTONIO GALINDO GARCIA;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;EUSEBIO CARRASCO VERA;PEDROFERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Presidente: ANTONIO GALINDO GARCIA. Secretario: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOSGARRE. Vicepresid.: EUSEBIO CARRASCO VERA. Cons.Del.Man: ANTONIO GALINDO GARCIA;PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;EUSEBIO CARRASCO VERA. Tesorero: MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN.Datos registrales. T 3001 , F 6, S 8, H MU 40727, I/A 31 (30.01.15).
17 de Septiembre de 2014Nombramientos. Cons.Del.Man: PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE. Datos registrales. T 3001 , F 6, S 8, H MU 40727,I/A 30 ( 9.09.14).
18 de Agosto de 2014Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS REFERENTE AL CAPITAL SOCIAL Y LASPARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 3001 , F 5, S 8, H MU 40727, I/A 29 (11.08.14).
05 de Marzo de 2014Otros conceptos: Modifican el articulo 28º de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3001 , F 5, S 8, H MU 40727, I/A 28(25.02.14).
28 de Noviembre de 2013Ampliación de capital. Capital: 42.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.493.000,00 Euros. Datos registrales. T 2745 , F 205, S 8, HMU 40727, I/A 27 (19.11.13).
18 de Junio de 2013Fe de erratas: POr error en su día se publicó la prórroga tácita de auditores de cuentas para los ejercicios 2.012 al 2.013, cuando enrealidad dicha prórroga fué para los ejercicios 2.012, 2.013 y 2.014. Datos registrales. T 2745 , F 205, S 8, H MU 40727, I/A 26 (7.06.13).
13 de Junio de 2013Reelecciones. Auditor: COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES SOCIEDA. Datos registrales. T 2745 , F 205, S 8,H MU 40727, I/A 26 ( 7.06.13).
19 de Marzo de 2013Otros conceptos: Modifican el segundo parrafo del Articulo 11º de los Estatutos Sociales. Página web de la sociedad. Creación dela página web corporativa: www.soltir.com. Datos registrales. T 2745 , F 205, S 8, H MU 40727, I/A 25 (11.03.13).
17 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO GALINDO GARCIA. Presidente: ANTONIO GALINDO GARCIA. Consejero: FELIX ROSVERA. Vicepresid.: FELIX ROS VERA. Consejero: JOSE DOMINGO PEREZ ROMERO;GINES VIDAL GARRE. Secretario: GINESVIDAL GARRE. Consejero: JUAN JOSE ALBALADEJO GARRE;JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ;DIEGO GARCIA LEON;MANUELRODRIGUEZ GUILLEN;ANTONIO MIGUEL LEON GARCIA. Cons.Del.Man: ANTONIO GALINDO GARCIA;FELIX ROS VERA;JOSEDOMINGO PEREZ ROMERO;GINES VIDAL GARRE;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN. Tesorero: JOSE DOMINGO PEREZROMERO;JOSE DOMINGO PEREZ ROMERO. Nombramientos. Consejero: ANTONIO GALINDO GARCIA;MANUEL RODRIGUEZGUILLEN;JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ;ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA;JUAN JOSE ALBALADEJO GARRE;EUSEBIOCARRASCO VERA;PEDRO FERNANDEZ-HENAREJOS GARRE;DIEGO ANTONIO GARCIA GARCIA. Presidente: ANTONIOGALINDO GARCIA. Secretario: ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA. Vicepresid.: JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ. Cons.Del.Man:ANTONIO GALINDO GARCIA;JOSE ANGEL DIAZ SANCHEZ;ANTONIO JESUS ZAPATA CONESA;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN.Tesorero: MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN. Datos registrales. T 2745 , F 204, S 8, H MU 40727, I/A 24 ( 8.02.12).
16 de Diciembre de 2011Otros conceptos: Modificacion de los articulos 11 y 19 referentes al capitalsocial y a la convocatoria de la junta, respectivamente.-Datos registrales. T 2745 , F 204, S 8, H MU 40727, I/A 23 ( 2.12.11).
14 de Octubre de 2010Nombramientos. Cons.Del.Man: MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN. Datos registrales. T 2745 , F 204, S 8, H MU 40727, I/A 22 (5.10.10).
16 de Junio de 2010Otros conceptos: SE MODIFICA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 11, LOS APARTADOS A), C), H), I) DEL ARTICULO 2,LOS APARTADOS B), E), G), J), M), N) Y Ñ) DEL ARTICULO 6, EL ARTICULO 7, EL ARTICULO 8, EL ARTICULO 31, EL ARTICULO33 Y SE REFUNDEN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio de objeto social. a) El cultivo agricola, lacomercializacion, manipulacion, envasado, distribucion, almacenamiento, conservacion, venta y transporte de productos agricolas,propios de las explotaciones de sus socios y de terceros. b) Asegurar la programacion de la produccion y su adaptacion a la demanda,especialmen. Datos registrales. T 2012 , F 59, S 8, H MU 40727, I/A 21 ( 7.06.10).
11 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: COMPAÑIA DE AUDITORIA CONSEJEROS AUDITORES SOCIEDA. Datos registrales. T 2012 , F 59, S 8,H MU 40727, I/A 20 ( 1.06.10).
23 de Diciembre de 2009Otros conceptos: SE MODIFICA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 2012 , F 59, S 8, H MU 40727, I/A 19 (14.12.09).
28 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO GALINDO GARCIA;FELIX GARRE SANZ;EMILIO ALFONSO MARTINEZMARTINEZ;SALVADOR MARTINEZ SANCHEZ;JOSE DOMINGO PEREZ ROMERO;FELIX ROS VERA;JUAN LUIS SANCHEZGARRE;MARIANO TORRES JIMENEZ;GINES VIDAL GARRE. Presidente: ANTONIO GALINDO GARCIA. Vicepresid.: GINES VIDALGARRE. Secretario: FELIX ROS VERA. Nombramientos. Consejero: ANTONIO GALINDO GARCIA. Presidente: ANTONIOGALINDO GARCIA. Consejero: FELIX ROS VERA. Vicepresid.: FELIX ROS VERA. Consejero: JOSE DOMINGO PEREZROMERO;GINES VIDAL GARRE. Secretario: GINES VIDAL GARRE. Consejero: JUAN JOSE ALBALADEJO GARRE;JOSE ANGELDIAZ SANCHEZ;DIEGO GARCIA LEON;MANUEL RODRIGUEZ GUILLEN;ANTONIO MIGUEL LEON GARCIA. Cons.Del.Man:ANTONIO GALINDO GARCIA;FELIX ROS VERA;JOSE DOMINGO PEREZ ROMERO;GINES VIDAL GARRE. Tesorero: JOSEDOMINGO PEREZ ROMERO. Datos registrales. T 2012 , F 59, S 8, H MU 40727, I/A 18 (19.05.09).