Actos BORME de Soller Sa
19 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Socio único: INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA. Representan: ORTEGA MORENO JUAN MANUEL. Adm.Unico: INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA. Revocaciones. Apoderado: MORENO RAMIREZ JOSE MARIA;VIRSEDA CABREROALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO;VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO;MORENORAMIREZ JOSE MARIA;VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO;MORENO RAMIREZ JOSEMARIA;VIRSEDA CABRERO ALBERTO;VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO;VIRSEDA CABREROALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO;ALCOBER TEIXIDO ALBERTO;ORTEGA MORENO JUAN MANUEL. Apo.Manc.:SUAREZ GONZALEZ JAVIER;BRUGUERA PAYET LLUIS;MARTINEZ BRU JAVIER. Apoderado: ARDERIU IBARS MARIAANGELES;FLORENCES COCA SERGIO. Apo.Sol.: ARDERIU IBARS MARIA ANGELES. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ JOSEALFONSO;MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 38311 , F 212, S 8, HM 66284, I/A 55 ( 9.08.19).
01 de Febrero de 2019Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2º, 5º Y 32º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Cambio deobjeto social. La Sociedad tiene como objeto social principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbanapara su arrendamiento. Adicionalmente, junto a la actividad económica derivada del objeto social principal, la Sociedad podrádesarrollar otras actividades accesorias, entendiéndose ... Datos registrales. T 11606 , F 225, S 8, H M 66284, I/A 54 (25.01.19).
13 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: MORENO RAMIREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 11606 , F 225, S 8, H M 66284, I/A 53 (5.09.18).
30 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO. Datos registrales. T 11606 , F 225, S 8, H M 66284, I/A51 (20.04.18).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO. Datos registrales. T 11606 , F 225, S 8, H M 66284, I/A52 (20.04.18).
15 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: ARDERIU IBARS MARIA ANGELES. Datos registrales. T 11606 , F 224, S 8, H M 66284, I/A 50 (6.03.18).
13 de Marzo de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: SUAREZ GONZALEZ JAVIER;BRUGUERA PAYET LLUIS;MARTINEZ BRU JAVIER. Datosregistrales. T 11606 , F 222, S 8, H M 66284, I/A 47 ( 5.03.18).
Nombramientos. Apoderado: ARDERIU IBARS MARIA ANGELES. Datos registrales. T 11606 , F 223, S 8, H M 66284, I/A 48 (5.03.18).
Nombramientos. Apoderado: FLORENCES COCA SERGIO. Datos registrales. T 11606 , F 223, S 8, H M 66284, I/A 49 ( 5.03.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRECENCIO. Datos registrales. T 11606 , F221, S 8, H M 66284, I/A 45 ( 2.03.18).
Nombramientos. Apoderado: ALCOBER TEIXIDO ALBERTO;ORTEGA MORENO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 11606 , F221, S 8, H M 66284, I/A 46 ( 2.03.18).
09 de Marzo de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA. Ceses/Dimisiones. Presidente:REDONDO PEREZ GERARDO. Secretario: REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO. Consejero: REDONDO PEREZPABLO;REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO;REDONDO PEREZ GERARDO. Con.Delegado: REDONDO PEREZ GERARDO.Nombramientos. Adm. Unico: INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA. Representan: ORTEGA MORENO JUAN MANUEL.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 10º, 18º, 19º, 20º, 21º Y 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- .Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Cambio de domiciliosocial. PASEO DE LA CASTELLANA 52 (MADRID). Datos registrales. T 11606 , F 220, S 8, H M 66284, I/A 44 ( 1.03.18).
07 de Diciembre de 2017Otros conceptos: NOTIFICADA LA EMISION DE VEINTITRES TITULOS MULTIPLES, NUMEROS 1 A 23, COMPRENSIVOS DELAS 420.000 ACCIONES AL PORTADOR, DE 6,01 EUROS DE VALOR NOMINAL CADA UNA, NUMEROS 1 AL 420.000, AMBOSINCLUSIVE.- Datos registrales. T 11606 , F 203, S 8, H M 66284, I/A 19/M (28.11.17).
27 de Septiembre de 2016Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 20 1 (MADRID). Datos registrales. T 11606 , F 220, S 8, H M 66284, I/A 43 (19.09.16).
23 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRECENCIO. Datos registrales. T 11606 ,F 215, S 8, H M 66284, I/A 42 (13.11.15).
05 de Agosto de 2015Reelecciones. Presidente: REDONDO PEREZ GERARDO. Secretario: REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO. Consejero:REDONDO PEREZ PABLO;REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO;REDONDO PEREZ GERARDO. Con.Delegado: REDONDOPEREZ GERARDO. Datos registrales. T 11606 , F 214, S 8, H M 66284, I/A 41 (28.07.15).
12 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: BRIONES SAENZ DE TEJADA IGNACIO. Datos registrales. T 11606 , F 214, S 8, H M 66284, I/A 40( 4.09.13).
05 de Septiembre de 2012Modificaciones estatutarias. 21. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 11606 , F 213, S 8, H M 66284, I/A 39(13.08.12).
10 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: ARNAUDIT SL. Datos registrales. T 11606 , F 213, S 8, H M 66284, I/A 38 (29.11.10).
27 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: VIRSEDA CABRERO ALBERTO;FERNANDEZ MARTIN CRESCENCIO. Datos registrales. T 11606 ,F 211, S 8, H M 66284, I/A 37 (15.10.10).
10 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ LAUCIRICA JESUS MARIA. Reelecciones. Presidente: REDONDO PEREZGERARDO. Secretario: REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO. Consejero: BRIONES SAENZ DE TEJADA IGNACIO;REDONDOPEREZ PABLO;REDONDO PEREZ MARIA DEL ROSARIO;REDONDO PEREZ GERARDO. Con.Delegado: REDONDO PEREZGERARDO. Datos registrales. T 11606 , F 210, S 8, H M 66284, I/A 36 (28.05.10).
05 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: MORISON AC SL. Datos registrales. T 11606 , F 210, S 8, H M 66284, I/A 35 (23.09.09).