Actos BORME de Solmar Selec Sl
08 de Enero de 2021Ceses/Dimisiones. Liquidador: NOVOCAR CENTRO DEL AUTOMOVIL SL EN LIQUIDACION. Adm. Unico: NOVOCAR CENTRODEL AUTOMOVIL SL EN LIQUIDACION. Nombramientos. Liquidador: NOVOCAR CENTRO DEL AUTOMOVIL SL ENLIQUIDACION. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 3763 , F 94, S 8, H A 57125, I/A 23 (29.12.20).
18 de Agosto de 2020Nombramientos. Adm. Unico: NOVOCAR CENTRO DEL AUTOMOVIL SL. Datos registrales. T 3763 , F 93, S 8, H A 57125, I/A 21 (7.08.20).
03 de Julio de 2019Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Unico: NOVOCAR CENTRO DEL AUTOMOVIL SL. Datos registrales. T 2299 ,F 80, S 8, H A 57125, I/A 6 C (21.06.19).
27 de Julio de 2018Nombramientos. Auditor: LST3 MARENOSTRUM SOLUCIONES GLOBALES SL. Datos registrales. T 3763 , F 93, S 8, H A 57125,I/A 20 (19.07.18).
09 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3763 , F 93, S 8, H A 57125, I/A 19 (28.02.18).
24 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: BLEDA SANCHEZ JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 3763 , F 93, S 8, H A 57125, I/A 18(16.10.17).
27 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: SALA MARTINEZ FUENSANTA. Datos registrales. T 3763 , F 93, S 8, H A 57125, I/A 17 (19.07.17).
18 de Enero de 2016Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3763 , F 92, S 8, H A 57125, I/A 14 ( 8.01.16).
02 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: BLEDA SANCHEZ JOSE FERNANDO. Datos registrales. T 2299 , F 82, S 8, H A 57125, I/A 13(26.03.14).
20 de Marzo de 2014P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: solmar.es. Datos registrales. T 2299 , F 82, S 8, H A 57125, I/A12 (11.03.14).