Actos BORME de Solucar Castilla Fv 1 Sa
05 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: ABAURRE LLORENTE RICARDO;SEAGE MEDELA SANTIAGO;DE LA TORRE IGLESIASANTONIO. Presidente: ABAURRE LLORENTE RICARDO. SecreNoConsj: MONTEAGUDO MORALES AMPARO. Nombramientos.LiqUnico: ABAURRE LLORENTE RICARDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Liquidador Unico. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 5231 , F 52, S 8, H SE 73518, I/A 9(26.03.13).
05 de Agosto de 2011Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ ENERGIA SOLAR 1 -
21 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: CA脩AS ROJANO ANTONIO. Datos registrales. T 5231 , F 51, S 8, H SE 73518, I/A 7 ( 3.06.11).
06 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: POU MANJON JUAN EUGENIO. Nombramientos. SecreNoConsj: MONTEAGUDO MORALESAMPARO. Datos registrales. T 5231 , F 50, S 8, H SE 73518, I/A 6 (28.03.11).
20 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: ABAURRE LLORENTE RICARDO. SecreNoConsj: MONTEAGUDO MORALES AMPARO.Revocaciones. Apo.Man.Soli: ABAURRE LLORENTE RICARDO;SEAGE MEDELA SANTIAGO;DE LA TORRE IGLESIASANTONIO;OLIVARES TIRADO EMILIO. Nombramientos. Presidente: ABAURRE LLORENTE RICARDO. SecreNoConsj: POUMANJON JUAN EUGENIO. Apo.Man.Soli: ABAURRE LLORENTE RICARDO;SEAGE MEDELA SANTIAGO;DE LA TORRE IGLESIASANTONIO;RUIZ GARCIA CRISTINA. Datos registrales. T 4659 , F 130, S 8, H SE 73518, I/A 5 ( 5.05.10).
16 de Julio de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: JIMENEZ-VELASCO MAZARIO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ FALCON AMANDO;GARCIA-QUILEZGOMEZ JESUS ANGEL;DE LAS CUEVAS TERAN FERNANDO. Otros conceptos: actuando dos cualesquiera de ellos de formamancomunada. Datos registrales. T 4659 , F 129, S 8, H SE 73518, I/A 4 ( 6.07.09).