Buscador CIF Logo

Actos BORME Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl

Actos BORME Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl - B63231096

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl con CIF B63231096

馃敊 Perfil de Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Solutions Four Engineering Bcn 2003 Sl

21 de Marzo de 2023
Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GUTIERREZ HERMIDA JAVIER;MARTORELL CASTILLO JUAN. Datos registrales. T 35837 , F214, S 8, H B 267837, I/A 10 (10.03.23).

12 de Enero de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: MARTORELL CASTILLO JUAN. PRESIDENTE: MARTORELL CASTILLO JUAN. CONSEJERO:GUTIERREZ HERMIDA JAVIER. CONS. DELEG.: MARTORELL CASTILLO JUAN. SECR.NO CONS: BALLESTER MU脩OZSANTIAGO. Nombramientos. AUDIT.INDIV.: FAIR AUDIT SLP. Datos registrales. T 35837 , F 213, S 8, H B 267837, I/A 9 (3.01.23).

19 de Septiembre de 2022
Revocaciones. CONSEJERO: NAVARRO HERENCIA JESUS. CONS. DELEG.: NAVARRO HERENCIA JESUS. Datos registrales.T 35837 , F 213, S 8, H B 267837, I/A 8 ( 9.09.22).

05 de Abril de 2019
Cambio de domicilio social. AV DE CERDANYOLA NUM.97 PG.IND.CAN MAGI (SANT CUGAT DEL VALLES). Cambio de objetosocial. LA ACTIVIDAD DE MECANICA EN GENERAL,MEDIANTE LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS DETRANSFORMACION DE METALES EJECUTADAS POR ENCARGO O SEGUN PLANOS APORTADOS POR EMPRESAS DECONSTRUCCION DE MAQUINARIA Y MATERIAL MECANICO. Datos registrales. T 35837 , F 213, S 8, H B 267837, I/A 7(28.03.19).

30 de Octubre de 2018
Revocaciones. SECRETARIO: NAVARRO HERENCIA JESUS. Nombramientos. CONS. DELEG.: MARTORELL CASTILLOJUAN;NAVARRO HERENCIA JESUS. SECR.NO CONS: BALLESTER MU脩OZ SANTIAGO. Datos registrales. T 35837 , F 212, S 8,H B 267837, I/A 6 (23.10.18).

30 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. ART. 5 : FIJACION DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, FINALIZANDO EL 30 DENOVIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 35837 , F 212, S 8, H B 267837, I/A 5 (21.12.16).

21 de Marzo de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: MARTORELL CASTILLO JUAN. PRESIDENTE: MARTORELL CASTILLO JUAN. CONSEJERO:OLIVELLA BERENGUER IVAN. SECRETARIO: OLIVELLA BERENGUER IVAN. CONSEJERO: IRIARTE ORTEGA ALVARO.Nombramientos. CONSEJERO: MARTORELL CASTILLO JUAN. PRESIDENTE: MARTORELL CASTILLO JUAN. CONSEJERO:NAVARRO HERENCIA JESUS. SECRETARIO: NAVARRO HERENCIA JESUS. CONSEJERO: GUTIERREZ HERMIDA JAVIER.Ampliaci贸n de capital. Capital: 24.949,80 Euros. Resultante Suscrito: 32.464,80 Euros. Cambio de objeto social. AMPLIAR EN:"YLA REALIZACION DE TRABAJOS DE SOLDADURA". Datos registrales. T 35837 , F 212, S 8, H B 267837, I/A 4 (13.03.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n