Actos BORME de Solwin Galicia Sl
24 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARRERA CORREA FERNANDO. Nombramientos. Apoderado: MENDEZ CAO MARIADOLORES;SUAREZ SUREDA EDUARDO. Datos registrales. T 29136 , F 28, S 8, H M 524576, I/A 15 (16.05.17).
21 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTOS CIFUENTES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 29136 , F 28, S 8, H M 524576, I/A 14(13.12.16).
13 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: BOLD SIMON. Nombramientos. Representan: SUAREZ SUREDA IGNACIO. Datos registrales.T 29136 , F 27, S 8, H M 524576, I/A 12 ( 5.11.15).
Nombramientos. Apoderado: BOLD SIMON. Datos registrales. T 29136 , F 27, S 8, H M 524576, I/A 13 ( 5.11.15).
04 de Noviembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SOLA MARISTANY ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: WINNERS APUESTAS SA.Representan: BOLD SIMON. Cambio de domicilio social. AVDA DE FUENCARRAL 44 - EDIFICIO TRIBECA 1, PLANTA(ALCOBENDAS). Datos registrales. T 29136 , F 27, S 8, H M 524576, I/A 11 (28.10.15).
28 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SOLA MARISTANY ALBERTO. Presidente: SOLA MARISTANY ALBERTO. Consejero: MORENOMOLINERO SANTIAGO. Secretario: MORENO MOLINERO SANTIAGO. Nombramientos. Adm. Unico: SOLA MARISTANYALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 29136 , F 26, S 8, H M 524576, I/A 10 (20.01.15).
27 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: BARADAD FRAMIS MARIA CARMEN. Con.Delegado: BARADAD FRAMIS MARIA CARMEN. Datosregistrales. T 29136 , F 26, S 8, H M 524576, I/A 9 (16.01.15).
28 de Junio de 2013Nombramientos. Apoderado: MARTOS CIFUENTES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 29136 , F 25, S 8, H M 524576, I/A 8(20.06.13).
22 de Mayo de 2013P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 29136 , F 25, S 8, H M 524576, I/A 6 (13.05.13).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 29136 , F 25, S8, H M 524576, I/A 7 (13.05.13).