Buscador CIF Logo

Actos BORME Sonopress Iber Memory Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sonopress Iber Memory Sa

Actos BORME Sonopress Iber Memory Sa - A78531035

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Sonopress Iber Memory Sa con CIF A78531035

馃敊 Perfil de Sonopress Iber Memory Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Sonopress Iber Memory Sa

06 de Octubre de 2015
Extinci贸n. Datos registrales. T 44546 , F 222, S 8, H B 459423, I/A 62 (28.09.15).

02 de Diciembre de 2014
Cambio de domicilio social. CL TRAVESSERA DE GRACIA 47-49 (BARCELONA). Datos registrales. T 44546 , F 221, S 8, H B459423, I/A 61 (19.11.14).

10 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA OBREGON ONIEVA ALBERTO. Secretario: GARCIA OBREGON ONIEVA ALBERTO.Nombramientos. Consejero: LLUNELL CARDONA JACINTO. Secretario: LLUNELL CARDONA JACINTO. Datos registrales. T31939 , F 148, S 8, H M 81075, I/A 60 ( 2.09.14).

11 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: CARBO JOFRA LUIS;GARCIA OBREGON ALBERTO. Apo.Man.Soli: GARCIA OBREGONALBERTO;BOGNAR ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: ARDERIU IBARS PEDRO;BOGNAR ENRIQUE;LLUNELL CARDONAJACINTO. Apo.Manc.: BOGNAR ENRIQUE;LLUNELL CARDONA JACINTO. Datos registrales. T 31939 , F 147, S 8, H M 81075, I/A59 ( 4.08.14).

25 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31939 , F 146, S 8, H M 81075, I/A58 (16.07.14).

30 de Junio de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA LLORCA FERNANDO. Datos registrales. T 31939 , F 146, S 8, H M 81075, I/A 57(17.06.14).

06 de Junio de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE. Datos registrales. T 31939 , F 146, S 8, H M 81075, I/A 56(29.05.14).

23 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE.Apo.Manc.: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;LOZANO MIGUEL JAVIER;GARCIA OBREGONALBERTO;GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUELJAVIER;GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE;CALLEJA CARBAJOSAJOSE-VICENTE. Apo.Sol.: CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA OBREGONALBERTO;BOGNAR ENRIQUE;CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE;GARCIA LLORCA FERNANDO. Datos registrales. T 25596, F 17, S 8, H M 81075, I/A 55 (11.04.14).

01 de Abril de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: MARCUELLO MESERO CARLOS. Apo.Manc.: MARCUELLO MESERO CARLOS;MARCUELLO MESEROCARLOS;MARCUELLO MESERO CARLOS;MARCUELLO MESERO CARLOS;MARCUELLO MESERO CARLOS. Nombramientos.Apo.Manc.: CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE;CALLEJA CARBAJOSA JOSE-VICENTE. Apo.Sol.: CALLEJA CARBAJOSAJOSE-VICENTE. Datos registrales. T 25596 , F 16, S 8, H M 81075, I/A 54 (25.03.14).

19 de Agosto de 2013
Reelecciones. Consejero: BOGNAR ENRIQUE;DEUTSCHMANN SVEN;GARCIA OBREGON ONIEVA ALBERTO. Presidente:DEUTSCHMANN SVEN. Secretario: GARCIA OBREGON ONIEVA ALBERTO. Datos registrales. T 25596 , F 16, S 8, H M 81075, I/A53 ( 8.08.13).

13 de Enero de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;MARCUELLO MESERO CARLOS.Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;MARCUELLO MESERO CARLOS;CALLEJACARBAJOSA JOSE-VICENTE. Apo.Manc.: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;MARCUELLO MESEROCARLOS. Datos registrales. T 25596 , F 13, S 8, H M 81075, I/A 52 ( 3.01.12).

03 de Enero de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25596 , F 13, S 8, H M 81075,I/A 51 (23.12.11).

28 de Enero de 2011
Revocaciones. Apoderado: GARCIA OBREGON ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER. Apo.Sol.: LOZANO MIGUELJAVIER;GARCIA OBREGON ALBERTO;MARCUELLO MESERO CARLOS. Apo.Manc.: MARCUELLO MESERO CARLOS;GARCIAOBREGON ONIEVA ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA OBREGONALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER;MARCUELLO MESERO CARLOS. Datos registrales. T 25596 , F 11, S 8, H M 81075, I/A 50(19.01.11).

27 de Agosto de 2009
Revocaciones. Apoderado: ARES JIMENEZ MARCIAL;CARBO JOFRA LUIS;CARBO DE PITARQUE LUIS;PELLICO BOSCHMARIANO;REY MARCOS EUSEBIO;SWIENTEK UWE;BENEYTO PEREZ JOSE MARIA;SANCHEZ WEICKGENANNTCRISTINA;KONIG ELISABETH;ARES JIMENEZ MARCIAL. Apo.Sol.: ARES JIMENEZ MARCIAL. Datos registrales. T 25596 , F 11,S 8, H M 81075, I/A 49 (18.08.09).

29 de Junio de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: MARCUELLO MESERO CARLOS. Apo.Manc.: MARCUELLO MESERO CARLOS;GARCIA OBREGONONIEVA ALBERTO;LOZANO MIGUEL JAVIER. Datos registrales. T 25596 , F 10, S 8, H M 81075, I/A 48 (17.06.09).

19 de Enero de 2009
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MEDIA FINANCE HOLDING SL. Datos registrales. T 25596 , F 10,S 8, H M 81075, I/A 47 ( 7.01.09).

12 de Enero de 2009
Otros conceptos: COMO CONSECUENCIA DE LA REVISION CATASTRAL DE 1 DE ENERO DE1995, SE HA CAMBIADO ELNUMERO DE LA CALLE DEL DOMICILIO DELA SOCIEDAD, POR LO QUE SU DOMICILIO ES EN COSLADA, AVDA. FUENTEMAR,37. Datos registrales. T 25596 , F 10, S 8, H M 81075, I/A 46 (29.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n