Buscador CIF Logo

Actos BORME Sopasa La Mancha Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sopasa La Mancha Sl

Actos BORME Sopasa La Mancha Sl - B45441961

Tenemos registrados 5 Actos BORME del Registro Mercantil de Toledo para Sopasa La Mancha Sl con CIF B45441961

馃敊 Perfil de Sopasa La Mancha Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Toledo

Actos BORME de Sopasa La Mancha Sl

08 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ORTIZ SANCHEZ JOSE;BRAVO BRAVO CELEDONIA. Presidente: ORTIZ SANCHEZ JOSE.

11 de Marzo de 2014
Revocaciones. Auditor: ABACO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1424 , F 153, S 8, H TO 13861, I/A 12 (3.03.14).

23 de Enero de 2014
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 213/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 31/07/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA E INSTRUCCION N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUANRAMON BRIGIDANO MARTINEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 213/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n31/07/2013. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado.Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA E INSTRUCCION N潞 1 Y DE LO MERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANOMARTINEZ. Resoluciones: Las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio del deudor quedan intervenidas por laadministraci贸n concursal mediante su autorizaci贸n o conformidad. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 213/2013. Fechade resoluci贸n 31/07/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 1& INSTANCIA E INSTRUCCION N潞 1 Y DE LOMERCANTIL DE TOLEDO. Juez: JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ. Administrador Concursal. Fecha 31/07/2013, NIF/CIF3743700J. GOMEZ DE LAS HERAS MARTIN MAESTRO LUIS. Auxiliar Delegado Concursal. Fecha 31/07/2013, NIF/CIF 04585555E.CA脩IZARES PACHECO INES MARIA. Datos registrales. T 1424 , F 153, S 8, H TO 13861, I/A 11 (16.01.14).

15 de Abril de 2013
Revocaciones. Aud.C.Con.: ABACO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 1424 , F 153, S 8, H TO 13861, I/A 10 (8.04.13).

26 de Mayo de 2011
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Vicepresid.: ORTIZ BRAVO JOSE-FELIX. Secretario: ORTIZ BRAVO JUAN-CARLOS.Vicesecret.: ORTIZ BRAVO JUAN DIEGO. Nombramientos. Vicepresid.: ORTIZ BRAVO JUAN DIEGO. Vicesecret.: ORTIZ BRAVOJUAN-CARLOS. Secretario: ORTIZ BRAVO JOSE-FELIX. Reelecciones. Consejero: ORTIZ SANCHEZ JOSE;BRAVO BRAVOCELEDONIA;ORTIZ BRAVO JUAN-CARLOS;ORTIZ BRAVO JOSE-FELIX;ORTIZ BRAVO JUAN DIEGO. Presidente: ORTIZSANCHEZ JOSE. Con.Delegado: ORTIZ SANCHEZ JOSE. Cons.Del.Sol: ORTIZ BRAVO JUAN-CARLOS;ORTIZ BRAVO JUANDIEGO;ORTIZ BRAVO JOSE-FELIX. Cons.Del.Man: ORTIZ BRAVO JUAN DIEGO;ORTIZ BRAVO JOSE-FELIX;ORTIZ BRAVOJUAN-CARLOS. Datos registrales. T 1424 , F 152, S 8, H TO 13861, I/A 9 (16.05.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n