Actos BORME de Southberg Holdings -spain- I, Sl
18 de Noviembre de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.605,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 153, S 8, H M514307, I/A 22 (11.11.21).
25 de Octubre de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.604,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 153, S 8, H M514307, I/A 21 (18.10.19).
05 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 - PLANTA CUARTA (MADRID). Datos registrales. T 29176 , F 152,S 8, H M 514307, I/A 20 (29.03.19).
06 de Noviembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.603,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 151, S 8, H M514307, I/A 19 (29.10.18).
08 de Agosto de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.602,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 151, S 8, H M514307, I/A 18 ( 1.08.16).
25 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 131 1潞 (MADRID). Datos registrales. T 29176 , F 151, S 8, H M 514307,I/A 17 (17.02.16).
30 de Septiembre de 2015Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 10, EL NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO NO CONSEJERODE RAFAEL GARCIA LLANEZA, CUANDO LO CORRECTO ES VICESECRETARIO NO CONSEJERO. Datos registrales. T 29176 ,F 146, S 8, H M 514307, I/A 10 (17.02.14).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.601,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 150, S 8, H M514307, I/A 16 (23.09.15).
26 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: DIEDERIK ROSENDAAL FRANCOIS;ANGE PALMERO PHILIPPE ANTOINE;GARRIGUESCALDERON BELEN. Otros conceptos: SE RATIFICA EL PODER QUE CONSTA INSCRITO BAJO LA INSCRIPCION 14 DE ESTASOCIEDAD. Datos registrales. T 29176 , F 149, S 8, H M 514307, I/A 15 (18.09.14).
25 de Septiembre de 2014Nombramientos. Apoderado: DIEDERIK ROSENDAAL FRANCOIS;ANGE PALMERO PHILIPPE ANTOINE;GARRIGUESCALDERON BELEN. Otros conceptos: Ha quedado cancelado el poder conferido el d铆a 16 de Enero de 2014 a favor de DonFrancois Diederik Rosendaal, Don Philippe Antoine Ange Palmero y Do帽a Bel茅n Garrigues Calder贸n, por extinci贸n del mismo el 16 deAbril de 2014.- Datos registrales. T 29176 , F 149, S 8, H M 514307, I/A 14 (16.09.14).
15 de Julio de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 158.600,00 Euros. Datos registrales. T 29176 , F 148, S 8, HM 514307, I/A 13 ( 7.07.14).
26 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN. VsecrNoConsj: MARTINEZ PA脩OS JOSE GABRIEL. Consejero:INTERTRUST (SPAIN) SA. Secretario: INTERTRUST (SPAIN) SA. Nombramientos. Consejero: GARRIGUES CALDERON BELEN.Secretario: GARRIGUES CALDERON BELEN. SecreNoConsj: GARCIA LLANEZA RAFAEL. Cambio de domicilio social. C/ AYALA66 (MADRID). Datos registrales. T 29176 , F 146, S 8, H M 514307, I/A 10 (17.02.14).
Revocaciones. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SA;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Apo.Manc.:ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datos registrales. T 29176 , F 147, S 8, H M 514307, I/A 11 (17.02.14).
Nombramientos. Apoderado: GARRIGUES CALDERON BELEN;DIEDERIK ROSENDAAL FRANCOIS;ANGE PALMERO PHILIPPEANTOINE. Datos registrales. T 29176 , F 147, S 8, H M 514307, I/A 12 (17.02.14).
22 de Octubre de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: OLE VAN DER VORM CAREL;MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Datos registrales. T29176 , F 146, S 8, H M 514307, I/A 9 ( 9.10.12).
14 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: OLE VAN DER VORM CAREL. Presidente: OLE VAN DER VORM CAREL. Nombramientos.Consejero: ANGE PALMERO PHILIPPE ANTOINE. Presidente: ANGE PALMERO PHILIPPE ANTOINE. Datos registrales. T 29176 ,F 146, S 8, H M 514307, I/A 8 ( 5.06.12).
27 de Enero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 70.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 73.600,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.000,00Euros. Resultante Suscrito: 88.600,00 Euros. Datos registrales. T 28566 , F 95, S 8, H M 514307, I/A 7 (16.01.12).
03 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: DIEDERIK ROSENDAAL FRANCOIS;OLE VAN DER VORM CAREL;PALMERO PHILIPPEANTOINE;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ;MARTINEZ DE OSABA ELGUEZABAL EUGENIA. Otrosconceptos: REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS BAJO EL EPIGRAFE "I. CUENTAS BANCARIAS" A DO脩A CARMENROZPIDE ORBEGOZO, DO脩A BEATRIZ DIEZ ARRANZ Y "INTERTRUST, SA", ORIGEN DE LA INSCRIPCION 5& DE ESTA HOJASOCIAL. Datos registrales. T 28566 , F 94, S 8, H M 514307, I/A 6 (21.10.11).
20 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SA;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Datosregistrales. T 28566 , F 94, S 8, H M 514307, I/A 5 ( 8.09.11).
04 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA LLANEZA RAFAEL;MARTINEZ PA脩OS JOSE GABRIEL;SUAREZ DE CENTI MARTINEZLUIS;LOPEZ BOMBO DAVID;RAMALLO MONTIS ALONSO;ASENSIO GIMENEZ SARA;MARTIN SAINZ JORGE JOAQUIN. Datosregistrales. T 28566 , F 93, S 8, H M 514307, I/A 4 (26.07.11).