Actos BORME de Spanpetrol Sl
07 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: ABEY GRAD SLP. Datos registrales. T 4368 , F 209, S 8, H M 72468, I/A 23 (30.09.22).
14 de Julio de 2021Cambio de domicilio social. C/ SEVERO OCHOA 3 - 1ª PLANTA, OFICINA 7B (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datos registrales. T4368 , F 209, S 8, H M 72468, I/A 22 ( 7.07.21).
24 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: ABEY GRAD SLP. Datos registrales. T 4368 , F 209, S 8, H M 72468, I/A 21 (17.02.20).
30 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: ABEY GRAD SLP. Datos registrales. T 4368 , F 209, S 8, H M 72468, I/A 20 (19.01.17).
21 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: TORRES REDONDO JOSE ANTONIO;TORRES REDONDO JOSE ANTONIO;MARTIN HERRERANICANOR. Datos registrales. T 4368 , F 208, S 8, H M 72468, I/A 19 (11.12.15).
19 de Agosto de 2015Nombramientos. Auditor: LAFUENTE AUDITORES ASOCIADOS SLP. Datos registrales. T 4368 , F 208, S 8, H M 72468, I/A 18(11.08.15).
30 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: MONTERO GALAN JOSE MARIA. Datos registrales. T 4368 , F 207, S 8, H M 72468, I/A 17(22.04.14).
21 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: FALCON PERDIDO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 4368 , F 206, S 8, H M 72468, I/A 15( 9.03.12).
Nombramientos. Apoderado: ROS FALCON LUCAS JOSE. Datos registrales. T 4368 , F 207, S 8, H M 72468, I/A 16 ( 9.03.12).
21 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. C/ VALLE DEL RONCAL 12 EDIFICIO ROS Y FALCON (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 4368 , F 206, S 8, H M 72468, I/A 14 (12.05.10).