Buscador CIF Logo

Actos BORME Spec Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Spec Sa

Actos BORME Spec Sa - A08537300

Tenemos registrados 30 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Spec Sa con CIF A08537300

🔙 Perfil de Spec Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Spec Sa

17 de Enero de 2023
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 46983 ,F 13, S 8, H B 76777, I/A 72 (10.01.23).

13 de Diciembre de 2022
Otros conceptos: DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO. NUEVO ACCIONISTA: MYEFFICO FINANCE 2 S.A.S.Datos registrales. T 46983 , F 13, S 8, H B 76777, I/A 71 ( 2.12.22).

14 de Octubre de 2022
Revocaciones. REPR.143 RRM: GUILLAUME BERBINAU. ADM.UNICO: TIMACO SPAIN SL. Nombramientos. ADM.UNICO:MYEFFICO FINANCE 2 SAS. REPR.143 RRM: GUILLAUME ANDRE DOMINIQUE MARIE BERBINAU. Otros conceptos: CAMBIODE SOCIO UNICO SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO MYEFFICO FINANCE,SAS. Datos registrales. T 46983 , F 12, S 8, H B76777, I/A 70 ( 6.10.22).

22 de Septiembre de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 46983 , F 12, S 8, H B 76777, I/A 69(14.09.21).

23 de Noviembre de 2020
Nombramientos. ADM.UNICO: TIMACO SPAIN SL. Datos registrales. T 46983 , F 12, S 8, H B 76777, I/A 68 (13.11.20).

02 de Septiembre de 2019
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 10,11 Y 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 46983 , F 11, S 8, H B 76777, I/A 67 (22.08.19).

09 de Agosto de 2019
Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ACCIONISTA UNICO: TIMACO SPAIN S.L. Datos registrales. T46983 , F 11, S 8, H B 76777, I/A 66 ( 1.08.19).

25 de Julio de 2019
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: PARES CASALA DANIEL. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARCELO DANIEL DOS REISRODRIGUEZ. Datos registrales. T 40137 , F 189, S 8, H B 76777, I/A 64 (18.07.19).

Revocaciones. APOD.SOL/MAN: MARTINEZ COLLS MARIA ANGELES. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARTINEZ COLLSMARIA ANGELES. Datos registrales. T 40137 , F 190, S 8, H B 76777, I/A 65 (18.07.19).

11 de Junio de 2019
Revocaciones. APODERADO: MARTINEZ COLLS ANGELES;MARTINEZ COLLS MARIA ANGELS;MARTINEZ COLLS MARIAANGELES.APODERAD.SOL: MARTINEZ COLLS ANGELES. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MARTINEZ COLLS MARIAANGELES. Datos registrales. T 40137 , F 188, S 8, H B 76777, I/A 63 (31.05.19).

06 de Noviembre de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 40137 , F 187, S 8, H B 76777, I/A 62(29.10.18).

09 de Agosto de 2017
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: PARES CASALA DANIEL. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: PARES CASALA DANIEL.APODERAD.SOL: MARTINEZ COLLS ANGELES. Datos registrales. T 40137 , F 187, S 8, H B 76777, I/A 61 (28.07.17).

07 de Diciembre de 2016
Otros conceptos: LA SOCIEDAD "AUREN AUDITORS BCN, SLP" SE HA EXTINGUIDO CONTINUANDO EN LA ACTIVIDAD DEAUDITORIA LA SOCIEDAD DE NUEVA CREACION "AUREN AUDITORES SP,SLP". Datos registrales. T 40137 , F 186, S 8, H B76777, I/A 60 N (28.11.16).

06 de Octubre de 2015
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUREN AUDITORS BCN SLP. Datos registrales. T 40137 , F 186, S 8, H B 76777, I/A 60(28.09.15).

10 de Septiembre de 2015
Revocaciones. APODERADO: GONZALEZ HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 40137 , F 186, S 8, H B76777, I/A 59 ( 3.09.15).

20 de Agosto de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ COMIN GRABALOS ALEJANDRO. Datos registrales. T 40137 , F 186, S 8, H B76777, I/A 58 (12.08.15).

12 de Junio de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: PARES PRATS JOAN. Nombramientos. ADM.UNICO: TIMACO SPAIN SL. REPR.143 RRM:GUILLAUME BERBINAU. Datos registrales. T 40137 , F 185, S 8, H B 76777, I/A 56 ( 5.06.15).

Nombramientos. APOD.SOL/MAN: PARES CASALA DANIEL. Datos registrales. T 40137 , F 185, S 8, H B 76777, I/A 57 ( 5.06.15).

17 de Noviembre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 185, S 8, H B 76777, I/A 55 (7.11.14).

28 de Mayo de 2014
Modificaciones estatutarias. ART.31.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 40137 , F 185, S 8, H B 76777, I/A 54 (20.05.14).

15 de Noviembre de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 184, S 8, H B 76777, I/A 53 (8.11.13).

15 de Abril de 2013
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: http://www.grupospec.com/. Datos registrales. T 40137 , F 184,S 8, H B 76777, I/A 52 ( 4.04.13).

23 de Octubre de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 184, S 8, H B 76777, I/A 51 (9.10.12).

24 de Agosto de 2012
Nombramientos. ADM.UNICO: PARES PRATS JOAN. Datos registrales. T 40137 , F 183, S 8, H B 76777, I/A 50 (14.08.12).

02 de Noviembre de 2011
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 183, S 8, H B 76777, I/A 49(20.10.11).

26 de Noviembre de 2010
Revocaciones. APODERADO: PEÑA FERRER ALBERTO. Datos registrales. T 40137 , F 183, S 8, H B 76777, I/A 48 (16.11.10).

22 de Octubre de 2010
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 183, S 8, H B 76777, I/A 47(13.10.10).

20 de Mayo de 2010
Revocaciones. APODERADO: MARTIN PLANELL ENRIC. Datos registrales. T 40137 , F 181, S 8, H B 76777, I/A 45 (10.05.10).

Nombramientos. APODERADO: PEÑA FERRER ALBERTO. Datos registrales. T 40137 , F 182, S 8, H B 76777, I/A 46 (10.05.10).

02 de Noviembre de 2009
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: TABULARIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 40137 , F 181, S 8, H B 76777, I/A 44(21.10.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información