Actos BORME de Spotahome Sl
28 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40912 , F 216, S 8, H M 581352, I/A 40 (20.12.23).
25 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Apo.Sol.: ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 40912 , F216, S 8, H M 581352, I/A 38 (18.09.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ PAVO ESTER;ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 40912 , F 216, S 8, H M581352, I/A 39 (18.09.23).
10 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40912 , F 215, S 8, H M 581352, I/A 37 ( 2.01.23).
21 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: SKINNER CLARE LOUISE. Nombramientos. Apoderado: MAGANTO PEREZ IRENE. Datos registrales.T 40912 , F 215, S 8, H M 581352, I/A 36 (14.09.22).
24 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: SARKANJ SASCHA. Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA VAZQUEZ JULIO JESUS. Datosregistrales. T 40912 , F 214, S 8, H M 581352, I/A 35 (17.06.22).
13 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ PIAMONTE 23 (MADRID). Datos registrales. T 40912 , F 214, S 8, H M 581352, I/A 34 ( 6.06.22).
03 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 40912 , F 214, S 8, H M 581352, I/A 33 (27.12.21).
15 de Junio de 2021Cambio de domicilio social. C/ FUENCARRAL NUMERO 123, 5潞 PUERTA B (MADRID). Datos registrales. T 37631 , F 157, S 8, HM 581352, I/A 28 ( 8.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA CERRADA ROBERTO. Apo.Manc.: GARBAYO TAVERA EDUARDO;ALONSOFERNANDEZ JORGE MANUEL. Datos registrales. T 37631 , F 158, S 8, H M 581352, I/A 29 ( 8.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORRES CERDAN LISA-ELENA. Apo.Manc.: GARCIA CERRADA ROBERTO. Datos registrales. T40912 , F 210, S 8, H M 581352, I/A 30 ( 8.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO FERNANDEZ JORGE MANUEL. Apo.Manc.: GARCIA CERRADA ROBERTO. Datosregistrales. T 40912 , F 211, S 8, H M 581352, I/A 31 ( 8.06.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARBAYO TAVERA EDUARDO. Apo.Manc.: GARCIA CERRADA ROBERTO. Datos registrales. T40912 , F 212, S 8, H M 581352, I/A 32 ( 8.06.21).
02 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA ORTIZ MARIA DEL PILAR. Apoderado: GARCIA ORTIZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T37631 , F 157, S 8, H M 581352, I/A 26 (26.05.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: BIANCHI BRUNO. Apoderado: BIANCHI BRUNO. Datos registrales. T 37631 , F 157, S 8, H M 581352,I/A 27 (26.05.21).
04 de Septiembre de 2020Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 20 (MADRID). Datos registrales. T 37631 , F 157, S 8, H M 581352, I/A 24(28.08.20).
Revocaciones. Apoderado: ACIN PEREZ MONTSERRAT;GARCIA PEREZ ESTHER. Apo.Sol.: BURNS ALAN ROBERT;VALEROGARCIA BEATRIZ. Datos registrales. T 37631 , F 157, S 8, H M 581352, I/A 25 (28.08.20).
19 de Mayo de 2020Nombramientos. Apoderado: SARKANJ SASCHA. Datos registrales. T 37631 , F 156, S 8, H M 581352, I/A 23 (11.05.20).
05 de Marzo de 2020Revocaciones. Apoderado: ALAMO ROA JUAN. Datos registrales. T 37631 , F 156, S 8, H M 581352, I/A 22 (27.02.20).
24 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: VAN DE WATER CHRISTOPHER MARTIN. Datos registrales. T 37631 , F 156, S 8, H M 581352, I/A 21(17.01.20).
17 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: BURNS ALAN ROBERT. Datos registrales. T 37631 , F 152, S 8, H M 581352, I/A 17 (10.01.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALERO GARCIA BEATRIZ. Datos registrales. T 37631 , F 153, S 8, H M 581352, I/A 18 (10.01.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: SKINNER CLARE LOUISE. Datos registrales. T 37631 , F 153, S 8, H M 581352, I/A 19 (10.01.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PAVO ESTER;ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 37631 , F 154, S 8, H M581352, I/A 20 (10.01.20).
02 de Diciembre de 2019Revocaciones. Apoderado: SANTAOLALLA BOLLAND LUCIA. Datos registrales. T 37631 , F 152, S 8, H M 581352, I/A 16(25.11.19).
03 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: VAN DE WATER CHRISTOPHER MARTIN. Datos registrales. T 37631 , F 151, S 8, H M 581352, I/A 13(24.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ MIGUEL PATRICIA. Datos registrales. T 37631 , F 151, S 8, H M 581352, I/A 14 (24.04.19).
Revocaciones. Apoderado: GOIRIZ CRIADO ALFONSO. Datos registrales. T 37631 , F 152, S 8, H M 581352, I/A 15 (24.04.19).
26 de Febrero de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ-PETEIRO FRANCO SARA. Apoderado: TALLON POYATO DANIEL. Datos registrales. T 37631 ,F 150, S 8, H M 581352, I/A 11 (19.02.19).
Nombramientos. Apoderado: ACIN PEREZ MONTSERRAT;GARCIA PEREZ ESTHER;ALVAREZ MIGUEL PATRICIA;GARCIAORTIZ MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 37631 , F 150, S 8, H M 581352, I/A 12 (19.02.19).
18 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32298 , F 150, S 8, H M 581352, I/A 10 (10.01.19).
26 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: SANTAOLALLA BOLLAND LUCIA;ALAMO ROA JUAN;GOIRIZ CRIADO ALFONSO. Datosregistrales. T 32298 , F 109, S 8, H M 581352, I/A 9 (19.07.18).
21 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: BIANCHI BRUNO. Datos registrales. T 32298 , F 108, S 8, H M 581352, I/A 7 (10.05.18).
Nombramientos. Apoderado: TALLON POYATO DANIEL. Datos registrales. T 32298 , F 108, S 8, H M 581352, I/A 8 (10.05.18).
14 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ-PETEIRO FRANCO SARA;GARCIA ORTIZ MARIA DEL PILAR;BIANCHI BRUNO. Datosregistrales. T 32298 , F 108, S 8, H M 581352, I/A 6 ( 7.05.18).
02 de Octubre de 2017Cambio de domicilio social. C/ VIZCAYA 12 (MADRID). Datos registrales. T 32298 , F 107, S 8, H M 581352, I/A 5 (22.09.17).
07 de Abril de 2016Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SPOTAHOME LIMITED. Cambio de domicilio social. C/ RODRIGUEZ SANPEDRO 10 LOCAL B (MADRID). Datos registrales. T 32298 , F 107, S 8, H M 581352, I/A 4 (30.03.16).
15 de Diciembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 312,50 Euros. Resultante Suscrito: 3.312,50 Euros. Datos registrales. T 32298 , F 105, S 8, H M581352, I/A 3 ( 4.12.14).