Buscador CIF Logo

Actos BORME Spotting Developments Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Spotting Developments Sl

Actos BORME Spotting Developments Sl - B87405429

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Spotting Developments Sl con CIF B87405429

馃敊 Perfil de Spotting Developments Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Spotting Developments Sl

29 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS. Apo.Manc.: OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS. Datosregistrales. T 43674 , F 81, S 8, H M 613443, I/A 21 (22.06.22).

21 de Junio de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ RENOVALES DAVID. Datos registrales. T 42574 , F 17, S 8, H M 613443, I/A 20(14.06.22).

25 de Enero de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PASCUAL ZARATE PILAR. Apoderado: CARDONA ARRANZ BELEN;LOIS CIGARRANPEDRO;CALVO GOMEZ JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: GUERRERO FERRER VICTOR MANUEL;HUMBERT GUILLAUME PIERREANTOINE MARIN;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ FERNANDEZ JOSEGERMAN;SUAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;MEDINA SANTAMARIA ARTURO;FREIRE BARRAL PABLO;LOPEZ GRANADOSBELEN;GONZALEZ TEJERA REBECA;LOPEZ-TELLO HERRERA JOSE CARLOS;TEJEDOR CUESTA OSCAR. Datos registrales. T42574 , F 17, S 8, H M 613443, I/A 19 (18.01.22).

12 de Enero de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ FERNANDEZ JOSE GERMAN. Apo.Sol.: LOPEZ FERNANDEZ JOSEGERMAN;OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS. Apo.Manc.: OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS;BARCENA PEROTASGUILLERMO. Apo.Sol.: BARCENA PEROTAS GUILLERMO. Datos registrales. T 42574 , F 7, S 8, H M 613443, I/A 16 ( 4.01.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: PASCUAL ZARATE PILAR. Apo.Sol.: PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 42574 , F 11, S8, H M 613443, I/A 17 ( 4.01.22).

Nombramientos. Apo.Manc.: DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS. Apo.Sol.: DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOIS CIGARRANPEDRO. Apo.Manc.: LOIS CIGARRAN PEDRO. Datos registrales. T 42574 , F 14, S 8, H M 613443, I/A 18 ( 4.01.22).

20 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GRANADOS BELEN. Datos registrales. T 42574 , F 2, S 8, H M 613443, I/A 11 (13.10.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ TEJERA REBECA. Datos registrales. T 42574 , F 4, S 8, H M 613443, I/A 12(13.10.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ-TELLO HERRERA JOSE CARLOS. Datos registrales. T 42574 , F 5, S 8, H M 613443, I/A13 (13.10.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR CUESTA OSCAR. Datos registrales. T 42574 , F 6, S 8, H M 613443, I/A 14 (13.10.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO;GARCIA SANCHEZ JESUS. Datos registrales. T 42574 , F 7, S 8,H M 613443, I/A 15 (13.10.21).

18 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: JUANAS FABEIRO ALEXANDRA. Datos registrales. T 34100 , F 120, S 8, H M 613443, I/A 6 (8.10.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 34100 , F 120, S 8, H M 613443, I/A 7 ( 8.10.21).

Nombramientos. Apoderado: CARDONA ARRANZ BELEN;LOIS CIGARRAN PEDRO;CALVO GOMEZ JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 34100 , F 123, S 8, H M 613443, I/A 9 (10.10.21).

Nombramientos. Apoderado: MARTOS RIPOLL JORGE. Datos registrales. T 34100 , F 122, S 8, H M 613443, I/A 8 (10.10.21).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUERRERO FERRER VICTOR MANUEL;HUMBERT GUILLAUME PIERRE ANTOINEMARIN;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS;LOPEZ FERNANDEZ JOSEGERMAN;SUAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL;MEDINA SANTAMARIA ARTURO;FREIRE BARRAL PABLO. Datos registrales. T34100 , F 124, S 8, H M 613443, I/A 10 (10.10.21).

08 de Junio de 2021
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: XFERA MOVILES SA. Datos registrales. T 34100 , F 120, S 8, H M 613443, I/A 5 (1.06.21).

03 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: SPENGER MEINRAD;GUERRERO FERRER VICTOR;DE LUCAS SANCHEZ MIGUEL. PresEjecutiv:SPENGER MEINRAD. Con.Delegado: SPENGER MEINRAD. SecreNoConsj: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO. Nombramientos.Adm. Unico: SPENGER MEINRAD. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Cambio de domicilio social. AVDA DE BRUSELAS 38 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 34100 , F 119,S 8, H M 613443, I/A 4 (27.05.21).

22 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: DE LUCAS SANCHEZ MIGUEL;GURREA-NOZALEDA HORNLEIN ENRIQUE. Nombramientos.Consejero: SPENGER MEINRAD;GUERRERO FERRER VICTOR;DE LUCAS SANCHEZ MIGUEL. PresEjecutiv: SPENGERMEINRAD. Con.Delegado: SPENGER MEINRAD. SecreNoConsj: CASTA脩EDA GONZALEZ ALBERTO. Otros conceptos: Cambiodel Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 34100 , F 119, S 8, H M613443, I/A 3 (15.10.19).

18 de Septiembre de 2019
Ampliaci贸n de capital. Capital: 27.938,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.027.938,00 Euros. Datos registrales. T 34100 , F 118, S 8,H M 613443, I/A 2 (11.09.19).

10 de Diciembre de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.10.15. Objeto social: 1.- La prestaci贸n y explotaci贸n de toda clase de servicios detelecomunicaciones y a tal efecto el dise帽o, instalaci贸n, conservaci贸n, refacci贸n, mejora, adquisici贸n, enajenaci贸n, interconexi贸n,

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n