Actos BORME de Spv Genia Davinci Sociedad Limitada
18 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: GALATA RAFFAELE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRREZABAL ARROYO GABRIEL. Apo.Manc.:BUTLER MONTERDE GABRIEL. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 189, S 8, H V 181901, I/A 10 (11.11.21).
20 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GALATA RAFFAELE. Nombramientos. Consejero: AGUIRREZABAL ARROYO GABRIEL. Cambiode domicilio social. AVDA RONDA DE NAZARET 9 BAJO (VALENCIA). Datos registrales. T 10497, L 7778, F 189, S 8, H V181901, I/A 9 (13.07.21).
11 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: APPENDINO MICHELE;RAVACCIA EZIO MARIO FRANCESCO ARMANDO;GALATARAFFAELE;CARBONERO MORALES RAUL;BUTLER MONTERDE GABRIEL. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 187, S 8, H V181901, I/A 8 ( 4.03.19).
20 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BUTLER MONTERDE GABRIEL. Nombramientos. Consejero: APPENDINO MICHELE;RAVACCIAEZIO MARIO FRANCESCO ARMANDO;GALATA RAFFAELE;BUTLER MONTERDE GABRIEL;CARBONERO MORALES RAUL.Presidente: RAVACCIA EZIO MARIO FRANCESCO ARMANDO. Secretario: BUTLER MONTERDE GABRIEL. Modificacionesestatutarias. Modificado el art. 8潞 de los Estatutos referente al modo de organizar la administraci贸n.. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 186, S 8, H V181901, I/A 5 (12.09.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BUTLER MONTERDE GABRIEL. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 187, S 8, H V 181901, I/A 6(12.09.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAVACCIA EZIO MARIO FRANCESCO ARMANDO. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 187, S8, H V 181901, I/A 7 (12.09.18).
27 de Agosto de 2018P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 10497, L 7778, F 186, S 8, H V 181901, I/A 4 (20.08.18).