Buscador CIF Logo

Actos BORME Srcl Consenur Cee Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Srcl Consenur Cee Sa

Actos BORME Srcl Consenur Cee Sa - A81098642

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Srcl Consenur Cee Sa con CIF A81098642

馃敊 Perfil de Srcl Consenur Cee Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Srcl Consenur Cee Sa

21 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;ALFEREZ GARCIA JOSE RAMON;LORENZO MARTINEZBEATRIZ;CABELLO DEL MAZO ROBERTO;GUTIERREZ BAEZA MARTA;GALINDO MARTINEZ JAIME;CARO REDONDOMARIA;QUINTIN CASANOVA MARIA JOSE;PEREZ GISBERT SANDRA;FALCON YEPEZ ELIECER JESUS;SEIJAS NIETOSANTIAGO. Nombramientos. Apoderado: RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;ALFEREZ GARCIA JOSE RAMON;LORENZOMARTINEZ BEATRIZ;CABELLO DEL MAZO ROBERTO;GUTIERREZ BAEZA MARTA;GALINDO MARTINEZ JAIME;CAROREDONDO MARIA;QUINTIN CASANOVA MARIA JOSE;PEREZ GISBERT SANDRA;FALCON YEPEZ ELIECER JESUS;JIMENEZGONZALEZ JOSE JUAN;SEIJAS NIETO SANTIAGO. Datos registrales. T 25239 , F 170, S 8, H M 146083, I/A 73 (14.12.23).

24 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;ALFEREZ GARCIA JOSE RAMON;LORENZO MARTINEZBEATRIZ;CABELLO DEL MAZO ROBERTO;GUTIERREZ BAEZA MARTA;GALINDO MARTINEZ JAIME;CARO REDONDOMARIA;QUINTIN CASANOVA MARIA JOSE;PEREZ GISBERT SANDRA;FALCON YEPEZ ELIECER JESUS;SEIJAS NIETOSANTIAGO. Datos registrales. T 25239 , F 166, S 8, H M 146083, I/A 72 (17.11.23).

20 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: DIAZ BERBEL IBA脩EZ PABLO. Apo.Sol.: DIAZ BERBEL IBA脩EZ PABLO. Datos registrales. T 25239 ,

15 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BERBEL HERNANDEZ PEDRO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 65陋 lapublicaci贸n del cese de BERBEL HERNANDEZ PEDRO como secretario no consejero. Datos registrales. T 25239 , F 163, S 8, H M146083, I/A 65 (11.06.20).

21 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 25239 , F 166, S 8, H M 146083, I/A 69 (14.11.22).

11 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ GONZALEZ JOSE JUAN;ROLAN ESTEVEZ ELDA;VILLAR VILLAR MANUEL;GALINDOMARTINEZ JAIME;CASTILLA MARTIN ELENA;CALVIN REY JORGE;GUTIERREZ BAEZA MARTA;SEIJAS NIETOSANTIAGO;QUINTIN CASANOVA MARIA JOSE;GARCIA TORRALBA SUSANA;FALCON YEPEZ ELIECER JESUS. Datosregistrales. T 25239 , F 165, S 8, H M 146083, I/A 68 ( 4.10.22).

30 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SEWARD WILLIAM JOHN. Datos registrales. T 25239 , F 164, S 8, H M 146083, I/A 66 (23.07.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ BERMUDEZ SALVADOR FRANCISCO JAVIER;RAICH DE CASTRO GLORIA;SUAREZFERNANDEZ PEDRO;MELON PARDO CARLOS RAMON;SORIANO MENDIARA PEDRO;MARCOS VAQUERO ZOILO. Datosregistrales. T 25239 , F 164, S 8, H M 146083, I/A 67 (23.07.21).

18 de Junio de 2020
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 25239 , F 163, S 8, H M 146083, I/A 64 (11.06.20).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HOMDEDEU TORTOSA JOSE;RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;DIAZ BERBEL IBA脩EZPABLO. Presidente: HOMDEDEU TORTOSA JOSE. Adm. Solid.: GUICE ROBERT JOHN. Nombramientos. Adm. Solid.: ROGERSKURT MATTHEW;GUICE ROBERT JOHN;GINNETTI DANIEL VINCENT;SEWARD WILLIAM JOHN. Modificaciones estatutarias.Modificado el art铆culo 18 de los estatutos sociales. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 25239 , F 163, S 8, H M 146083, I/A 65 (11.06.20).

30 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25239 , F 163, S 8, H M 146083, I/A 63 (22.05.18).

23 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: HOMDEDEU TORTOSA JOSE;DIAZ BERBEL IBA脩EZ PABLO;ALFEREZ GARCIA JOSERAMON;BERBEL HERNANDEZ PEDRO. Datos registrales. T 25239 , F 162, S 8, H M 146083, I/A 62 (16.05.18).

20 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: HOMDEDEU TORTOSA JOSE;RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;JOHN F. CLESEN.Presidente: HOMDEDEU TORTOSA JOSE. Secretario: RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj:BERBEL HERNANDEZ PEDRO. Consejero: HOMDEDEU TORTOSA JOSE;RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;DIAZ BERBELIBA脩EZ PABLO. Presidente: HOMDEDEU TORTOSA JOSE. Apoderado: RETAMERO MERINO FERMIN MANUEL;DIAZ BERBELIBA脩EZ PABLO;HOMDEDEU TORTOSA JOSE;BERBEL HERNANDEZ PEDRO. Datos registrales. T 25239 , F 162, S 8, H M146083, I/A 61 (13.12.17).

09 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 25239 , F 161, S 8, H M 146083, I/A 60 ( 1.09.15).

20 de Abril de 2015
Revocaciones. Apoderado: DEL RIO CEBRIAN PAOLA. Datos registrales. T 25239 , F 161, S 8, H M 146083, I/A 58 (13.04.15).

Ampliacion del objeto social. actividades relativas al marketing telefonico y atenci贸n al cliente -servicios de "Call Center"-, asi comolos servicios de gesti贸n administrativa en general. Datos registrales. T 25239 , F 161, S 8, H M 146083, I/A 59 (13.04.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n