Buscador CIF Logo

Actos BORME Srg Global Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Srg Global Spain Sl

Actos BORME Srg Global Spain Sl - B98588429

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Srg Global Spain Sl con CIF B98588429

馃敊 Perfil de Srg Global Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Srg Global Spain Sl

23 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ARNAU POMATA LUIS. Nombramientos. Apoderado: KERR ALISTAIR ROBERT;CAMPOS MARTINEZLIA JHOIS;KERR ALISTAIR ROBERT. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 92, S 8, H V 156929, I/A 23 (16.08.23).

27 de Septiembre de 2022
Fe de erratas: Los datos correctos de inscripci贸n del acto de Otorgamiento de poderes de fecha 29 de junio de 2022 son Tomo 10622Libro 7903 Folio 91 e inscripci贸n 22陋 y as铆 se hace constar para su correcta publicaci贸n en el Bolet铆n 180 de fecha 20/09/22 yreferencia 04208342022. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 91, S 8, H V 156929, I/A 22 (13.09.22).

20 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: MARINER TAMARIT OSCAR;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 10622, L 7903,F 91, S 8, H V 156929, I/A 21 (13.09.22).

14 de Marzo de 2022
Fe de erratas: El domicilio correcto es: Carretera de Valencia-Ademuz Km 30,5 Lliria (Valencia),y no el que por error se public贸 en elBolet铆n 239 de fecha 16/12/13 y referencia 05367292013. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 82, S 8, H V 156929, I/A 1 ( 9.12.13).

22 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ FABIEN FRANCOIS JACKY. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ HECTOR. Datosregistrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 21 (15.11.21).

16 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MARINER TAMARIT OSCAR. Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ SENABRE MARCIAL.Apo.Man.Soli: MARTINEZ SENABRE MARCIAL. Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datosregistrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 20 ( 9.11.21).

13 de Enero de 2020
Revocaciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 19 ( 3.01.20).

17 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MULAWA GREGORY JOHN. SecreNoConsj: HERRERA GARCIA ELENA. Nombramientos.Consejero: HERRERA GARCIA ELENA. Secretario: HERRERA GARCIA ELENA. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V156929, I/A 18 (10.12.19).

25 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: PRATER DAVID EDWARD. Presidente: PRATER DAVID EDWARD. Nombramientos. Consejero:GAUNT MERRITT EDWARD. Presidente: GAUNT MERRITT EDWARD. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929,I/A 17 (18.11.19).

06 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN;HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABREMARCIALApo.Man.Soli: IVORRA GARCIA MONCO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 197, S 8, H V 156929, I/A15 (27.02.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ FABIEN FRANCOIS JACKY;ARNAU POMATA LUIS;CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DELCARMEN. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 89, S 8, H V 156929, I/A 16 (27.02.19).

02 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL. Con.Delegado: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL.Nombramientos. Consejero: IVORRA GARCIA MONCO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 197, S 8, H V 156929,I/A 14 (25.09.18).

07 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIAL;MARINER TAMARIT OSCAR. Apo.Sol.:MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN;HERRERAGARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIALApo.Sol.: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 9807, L 7089,F 195, S 8, H V 156929, I/A 13 (26.04.18).

28 de Marzo de 2018
Revocaciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNGSL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 195, S 8, H V 156929, I/A 12 (21.03.18).

13 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Con.Delegado: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V156929, I/A 11 ( 4.12.17).

06 de Junio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: REIFENROTHER WOLFGANG WALTER. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ PEDREGALJOSE MANUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V 156929, I/A 10 (30.05.17).

22 de Febrero de 2017
Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V156929, I/A 9 (15.02.17).

20 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JOHNSON JASON. VsecrNoConsj: PEREZ MILLAN NURIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli:HERRERA GARCIA ELENA;JOHNSON JASON;PEREZ MILLAN NURIA;ALAMA ENGUIDANOS FRANCISCOApo.Sol.: JOHNSONJASON;HERRERA GARCIA ELENA. Nombramientos. SecreNoConsj: HERRERA GARCIA ELENA. VsecrNoConsj: MARINERTAMARIT OSCAR. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIAL;MARINER TAMARIT OSCAR.Apo.Sol.: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 192, S 8, H V 156929, I/A 8 ( 8.10.15).

25 de Septiembre de 2014
Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 7 (18.09.14).

15 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;JOHNSON JASON;PEREZ MILLAN NURIA;ALAMA ENGUIDANOSFRANCISCO Datos registrales. T 9717, L 6999, F 85, S 8, H V 156929, I/A 4 ( 8.07.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: JOHNSON JASON;HERRERA GARCIA ELENA. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 5 ( 8.07.14).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BAIRD KEVIN WILLIAM. Presidente: BAIRD KEVIN WILLIAM. Nombramientos. Consejero:REIFENROTHER WOLFGANG WALTER. Presidente: PRATER DAVID EDWARD. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 6 ( 8.07.14).

08 de Enero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.090.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.093.000,00 Euros. Datos registrales. T 9717, L 6999, F84, S 8, H V 156929, I/A 3 (30.12.13).

23 de Diciembre de 2013
Nombramientos. SecreNoConsj: JOHNSON JASON. Presidente: BAIRD KEVIN WILLIAM. VsecrNoConsj: PEREZ MILLAN NURIA.Datos registrales. T 9717, L 6999, F 84, S 8, H V 156929, I/A 2 (16.12.13).

16 de Diciembre de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.11.13. Objeto social: ARTICULO 2 .- Objeto social La Sociedad tendr谩 por objeto: a) Laadquisici贸n por cualquier t铆tulo, y enajenaci贸n de acciones y participaciones representativas de cualquier tipo de sociedades dedicadasa actividades de car谩cter empresarial e industrial. b) La prestaci贸n de servicios de asesoramiento. Domicilio: CTRA DE VALENCIA-ADEMUZ Km 30,4 (LLIRIA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SRG POLAND INVESTMENTSSARL. Nombramientos. Consejero: BAIRD KEVIN WILLIAM;PRATER DAVID EDWARD;MULAWA GREGORY JOHN. Datosregistrales. T 9717, L 6999, F 82, S 8, H V 156929, I/A 1 ( 9.12.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n