Actos BORME de Srg Global Spain Sl
23 de Agosto de 2023Revocaciones. Apo.Sol.: ARNAU POMATA LUIS. Nombramientos. Apoderado: KERR ALISTAIR ROBERT;CAMPOS MARTINEZLIA JHOIS;KERR ALISTAIR ROBERT. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 92, S 8, H V 156929, I/A 23 (16.08.23).
27 de Septiembre de 2022Fe de erratas: Los datos correctos de inscripci贸n del acto de Otorgamiento de poderes de fecha 29 de junio de 2022 son Tomo 10622Libro 7903 Folio 91 e inscripci贸n 22陋 y as铆 se hace constar para su correcta publicaci贸n en el Bolet铆n 180 de fecha 20/09/22 yreferencia 04208342022. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 91, S 8, H V 156929, I/A 22 (13.09.22).
20 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: MARINER TAMARIT OSCAR;MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 10622, L 7903,F 91, S 8, H V 156929, I/A 21 (13.09.22).
14 de Marzo de 2022Fe de erratas: El domicilio correcto es: Carretera de Valencia-Ademuz Km 30,5 Lliria (Valencia),y no el que por error se public贸 en elBolet铆n 239 de fecha 16/12/13 y referencia 05367292013. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 82, S 8, H V 156929, I/A 1 ( 9.12.13).
22 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ FABIEN FRANCOIS JACKY. Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ SANCHEZ HECTOR. Datosregistrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 21 (15.11.21).
16 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MARINER TAMARIT OSCAR. Revocaciones. Apo.Manc.: MARTINEZ SENABRE MARCIAL.Apo.Man.Soli: MARTINEZ SENABRE MARCIAL. Nombramientos. VsecrNoConsj: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datosregistrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 20 ( 9.11.21).
13 de Enero de 2020Revocaciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929, I/A 19 ( 3.01.20).
17 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: MULAWA GREGORY JOHN. SecreNoConsj: HERRERA GARCIA ELENA. Nombramientos.Consejero: HERRERA GARCIA ELENA. Secretario: HERRERA GARCIA ELENA. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V156929, I/A 18 (10.12.19).
25 de Noviembre de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: PRATER DAVID EDWARD. Presidente: PRATER DAVID EDWARD. Nombramientos. Consejero:GAUNT MERRITT EDWARD. Presidente: GAUNT MERRITT EDWARD. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 90, S 8, H V 156929,I/A 17 (18.11.19).
06 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN;HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABREMARCIALApo.Man.Soli: IVORRA GARCIA MONCO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 197, S 8, H V 156929, I/A15 (27.02.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: DIAZ FABIEN FRANCOIS JACKY;ARNAU POMATA LUIS;CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DELCARMEN. Datos registrales. T 10622, L 7903, F 89, S 8, H V 156929, I/A 16 (27.02.19).
02 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL. Con.Delegado: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL.Nombramientos. Consejero: IVORRA GARCIA MONCO JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 197, S 8, H V 156929,I/A 14 (25.09.18).
07 de Mayo de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIAL;MARINER TAMARIT OSCAR. Apo.Sol.:MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: CRUZADO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN;HERRERAGARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIALApo.Sol.: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 9807, L 7089,F 195, S 8, H V 156929, I/A 13 (26.04.18).
28 de Marzo de 2018Revocaciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNGSL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 195, S 8, H V 156929, I/A 12 (21.03.18).
13 de Diciembre de 2017Nombramientos. Con.Delegado: SANCHEZ PEDREGAL JOSE MANUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V156929, I/A 11 ( 4.12.17).
06 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: REIFENROTHER WOLFGANG WALTER. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ PEDREGALJOSE MANUEL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V 156929, I/A 10 (30.05.17).
22 de Febrero de 2017Reelecciones. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 194, S 8, H V156929, I/A 9 (15.02.17).
20 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: JOHNSON JASON. VsecrNoConsj: PEREZ MILLAN NURIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli:HERRERA GARCIA ELENA;JOHNSON JASON;PEREZ MILLAN NURIA;ALAMA ENGUIDANOS FRANCISCOApo.Sol.: JOHNSONJASON;HERRERA GARCIA ELENA. Nombramientos. SecreNoConsj: HERRERA GARCIA ELENA. VsecrNoConsj: MARINERTAMARIT OSCAR. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;MARTINEZ SENABRE MARCIAL;MARINER TAMARIT OSCAR.Apo.Sol.: MARTINEZ DE LECEA NOAIN ANA. Datos registrales. T 9807, L 7089, F 192, S 8, H V 156929, I/A 8 ( 8.10.15).
25 de Septiembre de 2014Nombramientos. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 7 (18.09.14).
15 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERRERA GARCIA ELENA;JOHNSON JASON;PEREZ MILLAN NURIA;ALAMA ENGUIDANOSFRANCISCO Datos registrales. T 9717, L 6999, F 85, S 8, H V 156929, I/A 4 ( 8.07.14).
Nombramientos. Apo.Sol.: JOHNSON JASON;HERRERA GARCIA ELENA. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 5 ( 8.07.14).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAIRD KEVIN WILLIAM. Presidente: BAIRD KEVIN WILLIAM. Nombramientos. Consejero:REIFENROTHER WOLFGANG WALTER. Presidente: PRATER DAVID EDWARD. Datos registrales. T 9717, L 6999, F 87, S 8, H V156929, I/A 6 ( 8.07.14).
08 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 7.090.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.093.000,00 Euros. Datos registrales. T 9717, L 6999, F84, S 8, H V 156929, I/A 3 (30.12.13).
23 de Diciembre de 2013Nombramientos. SecreNoConsj: JOHNSON JASON. Presidente: BAIRD KEVIN WILLIAM. VsecrNoConsj: PEREZ MILLAN NURIA.Datos registrales. T 9717, L 6999, F 84, S 8, H V 156929, I/A 2 (16.12.13).
16 de Diciembre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 22.11.13. Objeto social: ARTICULO 2 .- Objeto social La Sociedad tendr谩 por objeto: a) Laadquisici贸n por cualquier t铆tulo, y enajenaci贸n de acciones y participaciones representativas de cualquier tipo de sociedades dedicadasa actividades de car谩cter empresarial e industrial. b) La prestaci贸n de servicios de asesoramiento. Domicilio: CTRA DE VALENCIA-ADEMUZ Km 30,4 (LLIRIA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SRG POLAND INVESTMENTSSARL. Nombramientos. Consejero: BAIRD KEVIN WILLIAM;PRATER DAVID EDWARD;MULAWA GREGORY JOHN. Datosregistrales. T 9717, L 6999, F 82, S 8, H V 156929, I/A 1 ( 9.12.13).