Actos BORME de Statement Structure Sa
05 de Octubre de 2022Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 38247 , F 189, S 8, H M 568073, I/A 19 (28.09.22).
11 de Marzo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO BECERRA JUAN EVANGELISTA. Datos registrales. T 38247 , F 188, S 8, H M 568073,I/A 18 ( 4.03.21).
16 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38247 , F 188, S 8, H M 568073, I/A 17 ( 9.12.20).
20 de Julio de 2020Reelecciones. Adm. Unico: ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA. Representan: GARCIA ALTOZANOANGEL. Datos registrales. T 38247 , F 188, S 8, H M 568073, I/A 16 (13.07.20).
12 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 38247 , F 188, S 8, H M 568073, I/A 15 ( 5.11.19).
04 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31569 , F 21, S 8, H M 568073, I/A 14 (27.12.18).
15 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ MOLINILLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 31569 , F 20, S 8, H M 568073, I/A 10 (8.02.16).
Nombramientos. Apoderado: CARRION HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 31569 , F 20, S 8, H M 568073, I/A 11 (8.02.16).
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ MOLINILLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 31569 , F 21, S 8, H M 568073, I/A 12 ( 8.02.16).
Nombramientos. Apoderado: MATA ARBIDE ALEJANDRO. Datos registrales. T 31569 , F 21, S 8, H M 568073, I/A 13 ( 8.02.16).
14 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZORNOZA SOTO JOSE. Datos registrales. T 31569 , F 20, S 8, H M 568073, I/A 9 ( 3.12.15).
30 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31569 , F 19, S 8, H M 568073, I/A 8 (23.11.15).
06 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARANGO PAULA. Datos registrales. T 31569 , F 19, S 8, H M 568073, I/A 7 (24.04.15).
28 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA CRISTINA. Datos registrales. T 31569 , F 18, S 8,H M 568073, I/A 6 (15.04.14).
27 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: DEL VALLE PEREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 31569 , F 16, S 8, H M 568073, I/A 4 (19.11.13).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARANGO PAULA. Datos registrales. T 31569 , F 17, S 8, H M 568073, I/A 5 (19.11.13).
26 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MOLINILLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 31569 , F 15, S 8, H M 568073, I/A 2 (15.11.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ MOLINILLO JOSE LUIS;ZORNOZA SOTO JOSE;MATA ARBIDE ALEJANDRO;LARACANDEL RICARDO. Datos registrales. T 31569 , F 15, S 8, H M 568073, I/A 3 (15.11.13).
31 de Octubre de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 16.10.13. Objeto social: La realizaci贸n de inversiones en valores mobiliarios representativosdel capital social de entidades jur铆dicas... Domicilio: AVDA DE PIO XII, 102 (MADRID). Capital: 60.000,00 Euros. Nombramientos.Representan: GARCIA ALTOZANO ANGEL. Adm. Unico: ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA. Datosregistrales. T 31569 , F 12, S 8, H M 568073, I/A 1 (22.10.13).