Actos BORME de Steelgran Componentes Sa
06 de Junio de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: PABLO VILASECA MU脩OZ;JUAN BETERE KOPP;MIGUEL ANGEL CRESPO MARTINEZ.Nombramientos. Apo.Manc.: MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ ESTRADA. Datos registrales. T 1734 , F 77, S 8, H GR 27838,I/A 24 (29.05.23).
17 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ MU脩OZ MARIA TERESA;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Apo.Manc.: ESTEVEZBA脩ON MANUEL;GALLAR ROMERO ENRIQUE. Datos registrales. T 1734 , F 77, S 8, H GR 27838, I/A 23 (10.12.21).
05 de Marzo de 2021Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1734 , F 76, S 8, H GR 27838, I/A 21 (26.02.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESTEVEZ BA脩ON MANUEL;CRESPO MARTINEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1734 , F 77, S
26 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: VILASECA MU脩OZ PABLO;BETERE KOPP JUAN ALBERTO;CRESPO MARTINEZ MIGUELANGEL;GALLAR ROMERO ENRIQUE;GARCIA CIFUENTES BLANCA. Datos registrales. T 1490 , F 116, S 8, H GR 27838, I/A 20(19.08.20).
19 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTEVEZ BA脩ON MANUEL. Cons.Del.Man: ESTEVEZ BA脩ON MANUEL. Nombramientos.Consejero: SCHUBERT MARK. Cons.Del.Man: VILASECA MU脩OZ PABLO;SCHUBERT MARK. Reelecciones. Presidente: HOETZLSTEFAN. Datos registrales. T 1490 , F 115, S 8, H GR 27838, I/A 19 (12.03.20).
09 de Marzo de 2020Cambio de domicilio social. CTRA DE PULIANAS Km 6 (PULIANAS). Datos registrales. T 1490 , F 115, S 8, H GR 27838, I/A 18(27.02.20).
05 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA AGUSTIN CARLOS. Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA AGUSTIN CARLOS.Nombramientos. SecreNoConsj: WEGMANN LECUE TAMARA. Datos registrales. T 1490 , F 115, S 8, H GR 27838, I/A 17(28.11.19).
27 de Mayo de 2019Fe de erratas: Se rectifica el acto Nombramiento de miembro de 贸rgano adm. del envio 76 del a帽o 2019, en cuanto al error padecidoen el Sujeto nombrado con el cargo de PRESIDENTE, siendo el correcto HOETZL, STEFAN, y no "Vilaseca Mu帽贸z, Pablo", como porerror se remiti贸. Datos registrales. T 1490 , F 113, S 8, H GR 27838, I/A 15 (26.04.19).
23 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: VILASECA MU脩OZ PABLO;GARCIA AGUSTIN CARLOS;BETERE KOPP JUAN;ESTEVEZ BA脩ONMANUEL;CRESPO MARTINEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1490 , F 113, S 8, H GR 27838, I/A 16 (16.05.19).
06 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BORQUE SALAS ALBERTO;LOESER BERND OTTO;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO.Cons.Del.Man: LOESER BERND OTTO. Presidente: GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Cons.Del.Man: GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: HOETZL STEFAN;VILASECA MU脩OZ PABLO;ESTEVEZ BA脩ON MANUEL.Presidente: VILASECA MU脩OZ PABLO. Cons.Del.Man: VILASECA MU脩OZ PABLO;ESTEVEZ BA脩ON MANUEL. Datos registrales.T 1490 , F 113, S 8, H GR 27838, I/A 15 (26.04.19).
01 de Febrero de 2019Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.051.785,00 Euros. Desembolsado: 1.051.785,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.111.887,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.111.887,00 Euros. Otros conceptos: La ampliaci贸n de capital lleva aparejada una prima de emisi贸n de40.068 euros por acci贸n, lo que hace una prima total de 4.207.140 euros. Datos registrales. T 1490 , F 112, S 8, H GR 27838, I/A 14(25.01.19).
14 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA AGUSTINCARLOS. Datos registrales. T 1490 , F 112, S 8, H GR 27838, I/A 13 ( 5.12.17).
01 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO;WURMREINHOLD. Presidente: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Cons.Del.Sol: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO;WURMREINHOLD. Nombramientos. Consejero: LOESER BERND OTTO;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO;BORQUE SALASALBERTO. Presidente: GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Cons.Del.Man: LOESER BERND OTTO;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Reelecciones. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 1490 , F 112,S 8, H GR 27838, I/A 12 (25.08.16).
16 de Octubre de 2014Reelecciones. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Consejero: GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO;WURMREINHOLD;BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Presidente: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Cons.Del.Sol: BALDASANOSUPERVIELLE ARTURO;WURM REINHOLD. Datos registrales. T 1490 , F 112, S 8, H GR 27838, I/A 11 ( 9.10.14).
25 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ JIMENEZ FERNANDO;JIMENEZ MU脩OZ MARIA TERESA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:JIMENEZ MU脩OZ MARIA TERESA;GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1166 , F 118, S 8, H GR 27838,I/A 10 (18.06.13).
14 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: WURM REINHOLD. Consejero: GRAF KLAUS. Presidente: GRAF KLAUS. Nombramientos.Consejero: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Presidente: BALDASANO SUPERVIELLE ARTURO. Cons.Del.Sol: GALVEZPRIETO-MORENO ALEJANDRO;WURM REINHOLD. Datos registrales. T 1166 , F 118, S 8, H GR 27838, I/A 9 ( 6.05.13).
03 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUELANGEL. Datos registrales. T 1166 , F 118, S 8, H GR 27838, I/A 8 (25.07.12).
12 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: GARCIA ARIZA JESUS. Datos registrales. T 1166 , F 118, S 8, H GR 27838, I/A 7 ( 1.06.12).
28 de Octubre de 2011Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARIZA JESUS. Datos registrales. T 1166 , F 118, S 8, H GR 27838, I/A 6 (20.10.11).
17 de Noviembre de 2009Cambio de domicilio social. C/ SERREZUELA S/N - PARCELA MI 11-3, POLIGONO INDU (ESCUZAR). Datos registrales. T 1166, F 117, S 8, H GR 27838, I/A 5 ( 5.11.09).
23 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: INFANZON SUAREZ CARLOS. Con.Delegado: INFANZON SUAREZ CARLOS. Nombramientos.Consejero: GALVEZ PRIETO-MORENO ALEJANDRO. Con.Delegado: WURM REINHOLD. Reelecciones. Consejero: GRAFKLAUS;WURM REINHOLD. Presidente: GRAF KLAUS. Secretario: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Datos registrales. T 1166 , F 117, S8, H GR 27838, I/A 4 (14.10.09).