Buscador CIF Logo

Actos BORME Stein Von Liebig Balears I Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Stein Von Liebig Balears I Sl

Actos BORME Stein Von Liebig Balears I Sl - B57518599

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Stein Von Liebig Balears I Sl con CIF B57518599

馃敊 Perfil de Stein Von Liebig Balears I Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Stein Von Liebig Balears I Sl

08 de Junio de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;PEREZ MARCOSOSCAR;VALENCIA MU脩OZ PABLO. Datos registrales. T 43930 , F 70, S 8, H M 506949, I/A 10 ( 1.06.23).

09 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: GRUNER GEORG;HOHN JORG;KNOBEL MICHAEL;SCHOBER CHRISTIAN;SCHLOMMERWALTER;SCHRODER GERHARD;WONDRA ISABELLA. Datos registrales. T 43930 , F 70, S 8, H M 506949, I/A 9 ( 2.09.22).

23 de Agosto de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: Q-ENERGY ILMENITA SL. Representan: PAREJO DEL RIO DANIEL. Nombramientos. Adm.Unico: BARBUDO SEPULVEDA ENRIQUE. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Cambio de domicilio social.PASEO DE LA CASTELLANA 163 7 (MADRID). Datos registrales. T 28140 , F 136, S 8, H M 506949, I/A 8 (16.08.22).

28 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO. Fe de erratas: Se omiti贸 publicar por error en lainscripci贸n 5, el cese de MORENO GOROSTIZAGA FERNANDO como representante persona f铆sica. Datos registrales. T 28140 , F129, S 8, H M 506949, I/A 5 (21.08.19).

11 de Octubre de 2019
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: STEIN VON LIEBIG BALEARS XLVII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XLVIII SL.STEIN VON LIEBIG BALEARS XLIX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS L SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXVII SL. STEIN VONLIEBIG BALEARS XXXVIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXIX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XL SL. STEIN VON LIEBIGBALEARS XLI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XLII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XLIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARSXLIV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XLV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XLVI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXVII SL.STEIN VON LIEBIG BALEARS XXVIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXIX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXX SL. STEINVON LIEBIG BALEARS XXXI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXIII SL. STEIN VONLIEBIG BALEARS XXXIV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXXVI SL. STEIN VON LIEBIGBALEARS XVIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XIX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXISL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXIV SL. STEINVON LIEBIG BALEARS XXV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XXVI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XII SL. STEIN VON LIEBIGBALEARS XIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XIV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XVISL. STEIN VON LIEBIG BALEARS XVII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS II SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS III SL. STEIN VONLIEBIG BALEARS IV SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS V SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS VI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARSVII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS VIII SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS IX SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS X SL. STEIN VONLIEBIG BALEARS XI SL. STEIN VON LIEBIG BALEARS LI SL. Datos registrales. T 28140 , F 133, S 8, H M 506949, I/A 7 ( 4.10.19).

29 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: ASUERO RESUSTA VICENTE;GIMENEZ SORIANO PABLO;OLAGUIBEL AMICH I脩IGO;PEREZMARCOS OSCAR;VALENCIA MU脩OZ PABLO. Datos registrales. T 28140 , F 130, S 8, H M 506949, I/A 6 (21.08.19).

28 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DIF MANAGEMENT SPAIN SL;DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Nombramientos. Adm.Unico: Q-ENERGY ILMENITA SL. Representan: PAREJO DEL RIO DANIEL. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores mancomunados a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ JENNER 3 - 4陋 PLANTA(MADRID). Cambio de objeto social. EL DESARROLLO Y PROMOCIOND E PROTECTOS ENERGETICOS, LA COMPRA, VENTA,IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARALA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA. Datos registrales. T 28140 , F 129, S 8, H M 506949, I/A 5 (21.08.19).

04 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES. Nombramientos. Representan: MORENOGOROSTIZAGA FERNANDO. Datos registrales. T 28140 , F 129, S 8, H M 506949, I/A 4 (19.04.17).

02 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: BENDITO PRIETO CARLOS. Adm. Unico: TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT BV.Nombramientos. Representan: VIEILLESCAZES THOMAS CHARLES;BERRUECO GONZALEZ RAUL. Adm. Mancom.: DIFMANAGEMENT SPAIN SL;DIF MANAGEMENT FRANCE SARL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO MAURA 10 2潞(MADRID). Datos registrales. T 28140 , F 128, S 8, H M 506949, I/A 3 (23.05.14).

19 de Octubre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ JOSE ECHEGARAY 5 - PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 28140 , F 128, S 8, H M 506949, I/A 2 ( 6.10.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n